AMC (UK) ACQUISITION LIMITED

AMC (UK) ACQUISITION LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAMC (UK) ACQUISITION LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03878599
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Dirección de la sede social
    No 1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ODEON CINEMAS GROUP LIMITED25 feb 200025 feb 2000
    FAMEALPHA LIMITED17 nov 199917 nov 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    10 páginasLIQ13

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW

    2 páginasAD03

    Domicilio social registrado cambiado de No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ a No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ el 16 ene 2018

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de St Albans House 57-59 Haymarket London SW1Y 4QX a No 1 Colmore Square Birmingham B4 6HQ el 16 ene 2018

    2 páginasAD01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a Lee House 90 Great Bridgewater Street Manchester M1 5JW

    2 páginasAD02

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 19 dic 2017

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Notification de Odeon and Uci Cinemas Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov 2017

    2 páginasPSC02

    Cessation de Odeon Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov 2017

    1 páginasPSC07

    Nombramiento de Mr John Brooks Rainer como director el 20 nov 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Craig Ray Ramsey como director el 20 nov 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Craig Ray Ramsey como director el 20 nov 2017

    1 páginasTM01

    Estado de capital el 02 oct 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    8 páginasAA

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Nombramiento de Mr Craig Ray Ramsey como director el 06 jul 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Craig Ray Ramsey como director el 06 jul 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Stephen Alker como director el 06 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Neil James Williams como director el 06 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Jonathan Way como director el 06 jul 2017

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LAWTON, Kirsten
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Secretario
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    British50045660003
    RAINER, John Brooks
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    Director
    Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    No 1
    United StatesAmerican239691240001
    CAULTON, Lisa Victoria
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    Secretario
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    British68461080001
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Secretario
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    British124301460001
    HANLON, Hugh Ronald Victor
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    Secretario
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    British69843660001
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Secretario
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Secretario
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    ALKER, Andrew Stephen
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    United Kingdom
    United KingdomBritish120642230001
    ARNOLD, Gary Kenneth
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    Director
    8 The Wirrals
    ME5 0NT Chatham
    Kent
    British89207860001
    CAULTON, Lisa Victoria
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    Director
    Flat 2, 7 Castletown Road
    W14 9HE London
    British68461080001
    CHADD, Andrew Peter
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    Director
    The Old Pheasantry
    Woodcock Hill
    RH19 2RB Felbridge
    West Sussex
    United KingdomBritish133578890002
    DONOVAN, Paul Michael
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    England And Wales
    United Kingdom
    EnglandBritish154988050002
    GAVIN, Alexander Rupert, Sir
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Director
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish16875680002
    GOSLING, Steven Paul
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    Director
    5 Little Heath Lane
    Dunham Massey
    WA14 4TS Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish124301460001
    HANLON, Hugh Ronald Victor
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    Director
    First House
    First Avenue
    SW14 8SR London
    British69843660001
    HARRIS, Roger John
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Director
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish129109390001
    ISPAHANI, Farah Khanum
    30 Mount Ararat Road
    TW10 6PG Richmond
    Surrey
    Director
    30 Mount Ararat Road
    TW10 6PG Richmond
    Surrey
    British68461020002
    KACHINGWE, Mayamiko Allen Harrison
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    Director
    Flat 17
    Buckland Crescent
    NW3 5DH London
    Greater London
    British99741450001
    KEWARD, Barry James
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Director
    12 Felbridge Avenue
    Pound Hill
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British96966030001
    MASON, Jonathan Peter
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    Director
    Whitcomb Street
    WC2H 7DN London
    54
    United KingdomBritish117783520001
    MOORE, Gordon James
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    Director
    21 Bellevue Road
    SW13 0BJ London
    British64281120002
    MUNTON, Richard James
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    Director
    The Forge
    Hamptons
    TN11 9RE Tonbridge
    Kent
    British11882410003
    O'HAIRE, Cormac Patrick Thomas
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Director
    Sutherland Road
    Ealing
    W13 0DX London
    17
    Irish89259830001
    PRIDAY, Stuart Richard
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    Director
    72 Humphries Drive
    NN13 6PW Brackley
    Northamptonshire
    British89207570001
    PUNJA, Riaz
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    Director
    Apartment 31 Albert Bridge House
    127 Albert Bridge Road
    SW11 4PA London
    United KingdomBritish58870910002
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    UsaAmerican235440400001
    RAMSEY, Craig Ray
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    Director
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House
    UsaAmerican235473170001
    RITVAY, Alexander Tibor Mihaly, Dr
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    Director
    Mommsenstrasse 64
    FOREIGN 10629 Berlin
    Germany
    German95639320001
    SEGAL, Richard Lawrence
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    Director
    16 Spencer Drive
    N2 0QX London
    United KingdomBritish47031800003
    SMALLEY, Timothy John
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    Director
    Chivers Road
    CM15 0LG Stondon Massey
    Stondon Place
    Essex
    United KingdomBritish102593650002
    STEEL, Amanda Jayne
    Swinbrook
    Station Road Shiplake
    RG9 3JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Director
    Swinbrook
    Station Road Shiplake
    RG9 3JR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish126903200001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de AMC (UK) ACQUISITION LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Odeon And Uci Cinemas Group Limited
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57-59 Haymarket
    United Kingdom
    30 nov 2017
    57-59 Haymarket
    SW1Y 4QX London
    St Albans House, 57-59 Haymarket
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registro5194610
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    Odeon Limited
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    06 abr 2016
    Haymarket
    SW1Y 4QX London
    57-59
    England
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroUk
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies, Cardiff
    Número de registro3879590
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene AMC (UK) ACQUISITION LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 24 may 2011
    Entregado el 07 jun 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from odeon & uci bond midco limited or any restricted subsidiary to any creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of New York Mellon
    Transacciones
    • 07 jun 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 11 ene 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 04 abr 2007
    Entregado el 16 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the company's right, title and interest from time to time in and to each of the following assets the material property other than the excluded property the tangible movable property the accounts the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 16 abr 2007Registro de un cargo (395)
    • 26 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 03 dic 2004
    Entregado el 16 dic 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and any obligor to the chargee (the security agent as agent and trustee for the secured parties), the loan note holder and any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The material property other than the excluded property; the tangible moveable property; the accounts; the intellectual property; any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company; the investments; the shares, all dividends, interest and other monies payable in respect of the shares and all other related rights; all monetary claims and all related rights; and any other contract or agreement to which the company is a party (other than the specific contracts) and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2004Registro de un cargo (395)
    • 18 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 sept 2004
    Entregado el 24 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transacciones
    • 24 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 dic 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creado el 07 mar 2003
    Entregado el 26 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all of the property specified (for full details of property charged please see schedule to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Westlb Ag
    Transacciones
    • 26 mar 2003Registro de un cargo (395)
    • 17 sept 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Borrower debenture
    Creado el 16 dic 2002
    Entregado el 02 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the borrower secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the right title interest and benefit present and future in fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Bank of New York London Branch
    Transacciones
    • 02 ene 2003Registro de un cargo (395)
    • 21 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge over bank account
    Creado el 30 abr 2001
    Entregado el 09 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Expenditure required under the planned multiplex projects (as defined) in accordance with the terms of the credit agreement (as defined) and any moneys required to be repaid by the company to the chargee which have been drawn down pursuant to clause 8 of the investors and shareholders agreement (as defined) for planned multiplex projects but are not so required
    Breve descripción
    All the company's right title and interest in and to all sums deposited or to be deposited in the account and all other sums from time to time standing to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cinven Limited
    Transacciones
    • 09 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite debenture between (1) aceream limited (now known as odeon limited) (the parent) and others (including famealpha limited now known as odeon cinemas group limited) (as charging companies) and (2) merrill lynch international (as security agent)
    Creado el 19 feb 2000
    Entregado el 06 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due to the secured parties (as defined) (or any of them) by each charging company and each of the other obligors (as defined) (or any of them) under the senior finance documents (as defined)
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Merrill Lynch International as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 06 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 mar 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene AMC (UK) ACQUISITION LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    30 nov 2018Fecha de disolución
    19 dic 2017Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Profesional
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Profesional
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0