QUALITY CARE (SE) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | QUALITY CARE (SE) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03879714 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QUALITY CARE (SE) LIMITED?
- Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social
¿Dónde se encuentra QUALITY CARE (SE) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUALITY CARE (SE) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| QUALITY CARE (HOMECARE SERVICES) LIMITED | 18 nov 1999 | 18 nov 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QUALITY CARE (SE) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 sept 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUALITY CARE (SE) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Angela Culhane como director el 25 jun 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2011 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Jonathan David Calow como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Care Uk Services Ltd como secretario el 08 dic 2011 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 nov 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Paul John Watson como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 nov 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 10 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 páginas | MG01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2009 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Deborah Jane Marriott-Boam como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Geoffrey Benn como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Douglas Umbers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Angela Hector Culhane como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roy Hastings como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 nov 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Care Uk Services Ltd el 18 nov 2009 | 2 páginas | CH04 | ||||||||||
Cambio de datos del director Michael Robert Parish el 16 nov 2009 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QUALITY CARE (SE) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secretario | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | 165629830001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 151689670001 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 78828750003 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Secretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| HUXTABLE, Lynda Janet | Secretario | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67786330002 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LTD | Secretario corporativo | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Secretario designado corporativo | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Director | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| CULHANE, Angela | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 68602910001 | |||||||||
| HASTINGS, Roy | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| HUXTABLE, Lynda Janet | Director | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67786330002 | ||||||||||
| HUXTABLE, Roger David | Director | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67618160002 | ||||||||||
| QUINN, David Laurence, Mr. | Director | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | 123356660001 | |||||||||
| UMBERS, Douglas | Director | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Director | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Director designado corporativo | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004490001 |
¿Tiene QUALITY CARE (SE) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 21 jul 2010 Entregado el 26 jul 2010 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 16 mar 2007 Entregado el 04 abr 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 22 sept 2006 Entregado el 29 sept 2006 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 22 ene 2001 Entregado el 01 feb 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0