THE BALSAM CENTRE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE BALSAM CENTRE
    Estado de la empresaActiva
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited'
    Número de empresa 03898170
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE BALSAM CENTRE?

    • Educación preescolar (85100) / Educación
    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra THE BALSAM CENTRE?

    Dirección de la sede social
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE BALSAM CENTRE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WINCANTON COMMUNITY VENTURE22 dic 199922 dic 1999

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE BALSAM CENTRE?

    VencidoNo
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 mar 2026
    Próximas cuentas vencen el31 dic 2026
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2025

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE BALSAM CENTRE?

    Última declaración de confirmación cerrada hasta21 dic 2026
    Próxima declaración de confirmación vence04 ene 2027
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta21 dic 2025
    VencidoNo

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE BALSAM CENTRE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Cese del nombramiento de Sarah White como director el 23 ene 2026

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2025 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2025

    27 páginasAA

    Cese del nombramiento de Thomas Patrick Mcgauran como director el 15 dic 2025

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Frances Louise Da Cunha como director el 13 nov 2025

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Sarah White el 21 oct 2025

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Ms Anna Marie Lance como director el 08 may 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Neil Guy Trepess Polley como director el 08 may 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Jane Stella Knowles como director el 08 may 2025

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Ms Frances Elizabeth De Bosdari como director el 08 may 2025

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephan Paul White como director el 30 abr 2025

    1 páginasTM01

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed wincanton community venture\certificate issued on 27/02/25
    2 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 09 ene 2025

    RES15

    Exención de cambio de nombre del uso de "limitada" o "cyfyngedig"

    22 páginasNE01

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de David Edward Kemp como director el 05 feb 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Tamsin Lilias Graham como director el 10 ene 2025

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Cornelius Bartholemew como director el 09 ene 2025

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2024 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2024

    30 páginasAA

    Cese del nombramiento de Luanne Jones como secretario el 19 sept 2024

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Mark Richard Payne como secretario el 19 sept 2024

    2 páginasAP03

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2023

    31 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Luanne Jones como secretario el 22 dic 2023

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Edward Simon Sowerby como secretario el 22 dic 2023

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 21 dic 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de THE BALSAM CENTRE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PAYNE, Mark Richard
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Secretario
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    327337200001
    BAINBRIDGE, Michael Francis
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    United KingdomBritish253612790001
    DA CUNHA, Frances Louise
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish153039570001
    DE BOSDARI, Frances Elizabeth
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish92243860001
    HERMANSTEIN SMITH, Helen
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish204249240001
    KELLY, Michael James
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish192205140001
    KNOWLES, Jane Stella
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish183815950001
    LANCE, Anna Marie
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish335694540001
    POLLEY, Neil Guy Trepess
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish335631880001
    SHOWERING, Emily Frances Irene Ashley
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish235483630001
    COLLINGWOOD, Peter
    5 Parsons Gate
    BA7 7JS Castle Cary
    Somerset
    Secretario
    5 Parsons Gate
    BA7 7JS Castle Cary
    Somerset
    British74975610001
    JONES, Luanne
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Secretario
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    317386050001
    PORTER, Richard
    The Bakehouse
    BA8 0JT Templecombe
    Somerset
    Secretario
    The Bakehouse
    BA8 0JT Templecombe
    Somerset
    British95243800001
    SOWERBY, Edward Simon
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Secretario
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    175047550001
    UNDERWOOD, Desmond Frederick
    2 Linden Cottage
    North Street
    BA9 9BB Wincanton
    Somerset
    Secretario
    2 Linden Cottage
    North Street
    BA9 9BB Wincanton
    Somerset
    British59041910001
    WINTER, Lygia Jane
    The Cottage
    Compton Road, South Cadbury
    BA22 7EY Yeovil
    Somerset
    Secretario
    The Cottage
    Compton Road, South Cadbury
    BA22 7EY Yeovil
    Somerset
    British67564580001
    BAKER, Cheryl Anne Marian
    The Old Cottage
    Blackmoor Lane
    BA8 0SW Henstridge Templecombe
    Somerset
    Director
    The Old Cottage
    Blackmoor Lane
    BA8 0SW Henstridge Templecombe
    Somerset
    United KingdomBritish67564520001
    BARTHOLEMEW, John Cornelius
    Anchor Stores
    Yenston
    BA8 0NG Templecombe
    Somerset
    Director
    Anchor Stores
    Yenston
    BA8 0NG Templecombe
    Somerset
    United KingdomBritish67564500001
    BROOKS, Julian James
    Holbrook House 40 Saint James Street
    TA13 5BN South Petherton
    Somerset
    Director
    Holbrook House 40 Saint James Street
    TA13 5BN South Petherton
    Somerset
    British70666500001
    CARROLL, Timothy Guy Robin
    Orchard Cottage
    Barrow Lane Charlton Musgrove
    BA9 8HX Wincanton
    Somerset
    Director
    Orchard Cottage
    Barrow Lane Charlton Musgrove
    BA9 8HX Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish93929330001
    CASTLE, Douglas Glen
    48 Penn View
    BA9 9NE Wincanton
    Somerset
    Director
    48 Penn View
    BA9 9NE Wincanton
    Somerset
    British67564510001
    CHAUDOIR, Jennifer Ann
    11 Eastfield Road
    BA9 9LT Wincanton
    Somerset
    Director
    11 Eastfield Road
    BA9 9LT Wincanton
    Somerset
    British75209600001
    CHILTON, Andrew
    28 Grants Close
    BA9 9NS Wincanton
    Somerset
    Director
    28 Grants Close
    BA9 9NS Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish93929390001
    DEAN, Christine
    Sarendon House
    Mill Street
    BA9 9AP Wincanton
    Somerset
    Director
    Sarendon House
    Mill Street
    BA9 9AP Wincanton
    Somerset
    British80877090001
    DICKINSON, Robert Alan
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish203944690001
    ENGERT, Nigel Stewart
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    United KingdomBritish105265960001
    ENGERT, Nigel Stewart
    Latymer House
    Hill Close
    BA9 9NF Wincanton
    Somerset
    Director
    Latymer House
    Hill Close
    BA9 9NF Wincanton
    Somerset
    United KingdomBritish105265960001
    GODDARD, Anthony
    23 Grants Close
    BA9 9NS Wincanton
    Somerset
    Director
    23 Grants Close
    BA9 9NS Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish79117330001
    GRAHAM, Tamsin Lilias, Dr
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish290425550002
    GROOM, Helena Edith Maria
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish176693870001
    HAYWARD MBE, Shirley
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish175047590001
    HOPKINS, Jane Helen
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    Director
    The Balsam Centre
    Balsam Park
    BA9 9HB Wincanton
    Somerset
    EnglandBritish223193240001
    HUGHES, Sarah Teresa
    Castledene
    Queen Street Keinton Mandeville
    TA11 6EG Somerton
    Somerset
    Director
    Castledene
    Queen Street Keinton Mandeville
    TA11 6EG Somerton
    Somerset
    British95243680001
    ILLINGWORTH, Susan Clare
    Laburnam Cottage
    Westcombe
    BA4 6ER Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Laburnam Cottage
    Westcombe
    BA4 6ER Shepton Mallet
    Somerset
    British57056230002
    KEMP, David Edward
    Home Farm Lane
    Rimpton
    BA22 8AS Yeovil
    Beechfield House
    Somerset
    England
    Director
    Home Farm Lane
    Rimpton
    BA22 8AS Yeovil
    Beechfield House
    Somerset
    England
    EnglandBritish280158380002

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE BALSAM CENTRE?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    22 dic 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0