NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL
Visión general
| Nombre de la empresa | NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 03901460 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Dirección de la sede social | 250 Bishopsgate EC2M 4AA London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| RBS SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL | 23 oct 2014 | 23 oct 2014 |
| RBS GROUP MICRO FINANCE FUNDS | 25 sept 2008 | 25 sept 2008 |
| NATWEST COMMUNITY FINANCE FUND-THE WEST MIDLANDS | 23 dic 1999 | 23 dic 1999 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 03 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 19 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 19 nov 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Sara Kate Mcconnell Turnbull como director el 17 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gabriel Ng como director el 17 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Parita Doshi como director el 17 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joshua Meek como director el 17 sept 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2024 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Debra Phillips como director el 02 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Kirsty Lynn Anderson como director el 03 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kyle Macfarlane como secretario el 02 dic 2024 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Joseph Suffield como secretario el 02 dic 2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Kyle Macfarlane como secretario el 12 jul 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Perrett como secretario el 12 jul 2023 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Anshu Mandal como director el 01 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Niamh Goggin como director el 13 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 18 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de The Royal Bank of Scotland Group Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Cambio de datos del director Benjamin Paul Fraser Smith el 20 feb 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de John Dixon como director el 14 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUFFIELD, Joseph | Secretario | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | 330085430001 | |||||||
| ANDERSON, Kirsty Lynn | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Scotland | British | 334359230001 | |||||
| DIXON, John | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 300598850001 | |||||
| HARRISON, Andrew James | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 265589470001 | |||||
| MANDAL, Anshu | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 121096260001 | |||||
| MOHAMMED, Ash | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 239488380001 | |||||
| NG, Gabriel | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | England | British | 341589050001 | |||||
| SMITH, Benjamin Paul Fraser | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 251228160002 | |||||
| TURNBULL, Sara Kate Mcconnell, Mx | Director | High Street SA1 1NG Swansea 158 Wales | Wales | British,Irish | 220943890002 | |||||
| GOW, Morven | Secretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn United Kingdom | 171691470001 | |||||||
| HOCKLY, Martin Kenneth | Secretario | 38 Coppice Road Moseley B13 9DP Birmingham West Midlands | British | 102962560001 | ||||||
| HUGHES, Peter Kemp | Secretario | 513 Lexington Building Fairfield Road E3 2UF London | British | 53859650002 | ||||||
| MACFARLANE, Kyle | Secretario | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | 311409130001 | |||||||
| MANNING, Graeme | Secretario | First Floor, 12-14 Regent Place Hockley B1 3NJ Birmingham West Midlands | 167413800001 | |||||||
| MILLER, Helen | Secretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 206671130002 | |||||||
| PERRETT, Andrew | Secretario | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | 285196790001 | |||||||
| RAMAGE, Kate Alexandra | Secretario | Glasgow Road EH12 1HQ Edinburgh Rbs Gogarburn Scotland | 240929800001 | |||||||
| ROBINSON, Andrew John | Secretario | 1 Wallcrouch Farm Cottage High Street Wallcrouch TN5 7JH Wadhurst East Sussex | British | 54298980001 | ||||||
| BERRY, Jennifer Claire | Director | Furberry Court Grotton OL4 5JH Oldham 2 England | England | British | 101645900005 | |||||
| BRODIE, Robert Duncan | Director | High St. Agnesgate HG4 1QR Ripon 16 North Yorkshire England | England | British | 152841430001 | |||||
| DOSHI, Parita | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | England | British | 273653890001 | |||||
| GOGGIN, Niamh | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Northern Ireland | Irish | 143060390001 | |||||
| HARRISON, Neil Charles | Director | Ebor House, 5 Corriander Drive Elsenham CM22 6DL Bishops Stortford Hertfordshire | British | 70921530001 | ||||||
| HUGHES, Peter Kemp | Director | 513 Lexington Building Fairfield Road E3 2UF London | United Kingdom | British | 53859650002 | |||||
| JACOBS, Simon Anthony | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 280 England | England | British | 184419960001 | |||||
| JOHNSTONE, Stuart Christopher | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 238762180001 | |||||
| KENRICK, Thom Jolyon | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | Scotland | British | 151913320001 | |||||
| MEEK, Joshua | Director | B1 2JB Birmingham 4 Brindley Place United Kingdom | United Kingdom | British | 300476060001 | |||||
| MOIR, Stephen | Director | 1a Hopetoun Terrace EH31 2DD Gullane East Lothian | United Kingdom | British | 78329540002 | |||||
| MORGAN, Bernadette Mary | Director | La Belle Alliance Square CT11 8HZ Ramsgate 26 Kent England | England | British | 155151790001 | |||||
| MUNRO, Eric Allison | Director | 13 Nith Drive PA4 0UR Renfrew Renfrewshire | Scotland | British | 108781620001 | |||||
| PARSONS, Mark Richard | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | England | British | 167353770002 | |||||
| PHILLIPS, Debra | Director | Bishopsgate EC2M 4AA London 250 England | United Kingdom | British | 275547230001 | |||||
| PRABHU, Maya Antonia Mascarenhas | Director | WC2R 0QS London 440 Strand England | England | British | 193521850001 | |||||
| ROBINSON, Andrew John | Director | Primmers Green Cousley Wood Road TN5 6DY Wadhurst Long View East Sussex England | England | Canadian | 54298980002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de NATWEST SOCIAL & COMMUNITY CAPITAL?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natwest Group Plc | 06 abr 2016 | EH2 2YB Edinburgh 36 St Andrew Square Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0