ARTILIUM GROUP LIMITED

ARTILIUM GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARTILIUM GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03904535
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARTILIUM GROUP LIMITED?

    • Otras actividades de telecomunicaciones (61900) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    201 Haverstock Hill
    NW3 4QG London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARTILIUM GROUP PLC02 oct 201802 oct 2018
    ARTILIUM PLC23 may 200723 may 2007
    FUTURE INTERNET TECHNOLOGIES PLC02 jun 200002 jun 2000
    GRIFF-TECH.COM PLC06 ene 200006 ene 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 04 ene 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Bart Weijermars como director el 24 nov 2022

    1 páginasTM01

    Registro de la carga 039045350011, creada el 25 abr 2022

    86 páginasMR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    28 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Memorándum y Estatutos

    27 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cese del nombramiento de Rupert George Hutton como director el 03 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Rupert George Hutton como director el 03 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Bote De Vries como director el 29 may 2020

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Yves Van Sante como director el 01 jun 2020

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 039045350009

    1 páginasMR04

    Exercice comptable précédent prolongé du 30 jun 2019 au 31 dic 2019

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 06 ene 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 039045350010

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 039045350008

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 039045350007

    1 páginasMR04

    Registro de la carga 039045350010, creada el 19 mar 2019

    79 páginasMR01

    Notification de Pareteum Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 oct 2018

    2 páginasPSC02

    legacy

    4 páginasRP04CS01

    Registro de la carga 039045350009, creada el 26 feb 2019

    44 páginasMR01

    ¿Quiénes son los directivos de ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CANT, Jan
    Vaartdijkstraat 19
    8200 Brugge
    Vaartdijkstraat
    Belgium
    Secretario
    Vaartdijkstraat 19
    8200 Brugge
    Vaartdijkstraat
    Belgium
    238434200001
    KORFF, Alexander
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    Director
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    United KingdomDutchDirector255304750001
    AVWUNU, George
    118 Stafford Road
    CR0 4NF Croydon
    Surrey
    Secretario
    118 Stafford Road
    CR0 4NF Croydon
    Surrey
    BritishCompany Secretary75853510001
    FERNS, Tom
    St Andrew Street
    EC4V 3AF London
    9-13
    Secretario
    St Andrew Street
    EC4V 3AF London
    9-13
    British184036860001
    GOODWIN, Roger
    27 Willifield Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XU London
    Secretario
    27 Willifield Way
    Hampstead Garden Suburb
    NW11 7XU London
    BritishChartered Accountant37042500002
    ODRISCOLL, Nigel
    Stoke Poges Way
    Collum Green Road
    SL2 3RH Farnham Common
    Slough
    Secretario
    Stoke Poges Way
    Collum Green Road
    SL2 3RH Farnham Common
    Slough
    BritishCertified Accountant87273310001
    MOFO SECRETARIES LIMITED
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro05502549
    108015160001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    ARMSTRONG, Richard James
    8 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    Director
    8 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    EnglandBritishDirector69869290001
    BISSELING, Maarten
    c/o Mofo Notices Limited
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint
    United Kingdom
    Director
    c/o Mofo Notices Limited
    One Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint
    United Kingdom
    FranceNetherlandsDirector167538280001
    BONNIER, Robert Johan Henri
    19 Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    Director
    19 Pembroke Gardens Close
    W8 6HR London
    DutchDirector111736340001
    BRISTOW, Geoffrey John, Dr
    Panniers Farm Castle Lane
    Wookey
    BA5 1NL Wells
    Somerset
    Director
    Panniers Farm Castle Lane
    Wookey
    BA5 1NL Wells
    Somerset
    BritishBusiness Consultant35929320004
    CASAER, Tom
    Heistraat 252
    2610 Wilrijk
    Belgium
    Director
    Heistraat 252
    2610 Wilrijk
    Belgium
    BelgianDirector117274680001
    CHATRATH, Adosh
    Woodlands
    Northgate
    HA6 2TH Northwood
    Middlesex
    Director
    Woodlands
    Northgate
    HA6 2TH Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishSolicitor82669160001
    COX, Peter Jonathan
    38 Ide Lane
    Alphington
    EX2 8UT Exeter
    Devon
    Director
    38 Ide Lane
    Alphington
    EX2 8UT Exeter
    Devon
    EnglandBritishDirector74594510001
    DE JONG, Peter Ca
    c/o Mofo Notices Limited
    Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint One
    United Kingdom
    Director
    c/o Mofo Notices Limited
    Ropemaker Street
    EC2Y 9AW London
    Citypoint One
    United Kingdom
    NetherlandsNetherlandsStrategic Advisor164458090001
    DE PAUW, Wim Johan Frans
    Beekstraat
    2180 Ekeren
    17/19
    Antwerp
    Belgium
    Director
    Beekstraat
    2180 Ekeren
    17/19
    Antwerp
    Belgium
    BelgianDirector137135720001
    DE VRIES, Bote
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    Director
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    NetherlandsDutchFinancial Consultant194330030001
    DORENBOS, Gerard
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    Director
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    NetherlandsDutchDirector202966330001
    FAHID, Farhad Frederick
    Flat G
    8 Ennismore Gardens
    SW7 1NL London
    Director
    Flat G
    8 Ennismore Gardens
    SW7 1NL London
    BritishVenture Capitalist75373360001
    GRATTON, Paul Robert
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    Director
    The Hall
    Somersal Herbert
    DE6 5PD Ashbourne
    Derbyshire
    United KingdomBritishDirector47117090003
    HOOPER, Richard
    4 Western Road
    Fortis Green
    N2 9HX London
    Director
    4 Western Road
    Fortis Green
    N2 9HX London
    United KingdomBritishNon Executive Director5653280001
    HULME, Michael Keith
    Annbec House Plumtree
    Heversham
    LA7 7ER Milnthorpe
    Cumbria
    Director
    Annbec House Plumtree
    Heversham
    LA7 7ER Milnthorpe
    Cumbria
    United KingdomBritishDirector54689670002
    HUTTON, Rupert George
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    Director
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    EnglandBritishCfo206357020001
    HUTTON, Rupert George
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    Director
    NW3 4QG London
    201 Haverstock Hill
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector206357020001
    LANE, Christopher Ronald
    Goosehill Pitminster
    TA3 7SA Taunton
    Somerset
    Director
    Goosehill Pitminster
    TA3 7SA Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishCeo65620920002
    LEIGH-WOOD, Nicholas
    19 St Peters Road
    W6 9BA London
    Director
    19 St Peters Road
    W6 9BA London
    BritishCompany Director49455100002
    LO, Sonia
    123 Woodsford Square
    W14 8DT London
    Director
    123 Woodsford Square
    W14 8DT London
    United KingdomBritishDirector97162810001
    LYNCH, Kieran Anthony
    41 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    Director
    41 Chelverton Road
    Putney
    SW15 1RN London
    IrishDirector113852030001
    MARCUS, Robert
    3634 W Ames Lake Dr. Ne
    Redmond
    Washington 98053
    Usa
    Director
    3634 W Ames Lake Dr. Ne
    Redmond
    Washington 98053
    Usa
    United StatesChief Executive120825050001
    MENKE, Jan Paul
    St. Andrew Street
    EC4A 3AF London
    9-13
    Director
    St. Andrew Street
    EC4A 3AF London
    9-13
    SwitzerlandBritishDirector166110120001
    MORLEY, John David Christopher
    Cheveney
    Vicarage Road Yalding
    ME18 6DY Maidstone
    Kent
    Director
    Cheveney
    Vicarage Road Yalding
    ME18 6DY Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector203626460002
    MORLEY, Patrick
    St Andrew Street
    EC4A 3AF London
    9-13
    Uk
    Director
    St Andrew Street
    EC4A 3AF London
    9-13
    Uk
    The NetherlandsIrishDirector184657060001
    MULDER, Alfred
    280 Avenue Des Czetes
    Les Issambres
    Var 83380
    Director
    280 Avenue Des Czetes
    Les Issambres
    Var 83380
    FranceDutchDirector135329960001
    NINKOV, Mladen
    165 Waratah Place
    Dalkeith 6009
    Western Australia
    Australia
    Director
    165 Waratah Place
    Dalkeith 6009
    Western Australia
    Australia
    AustraliaAustralianInvestment Banker68087220002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ARTILIUM GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Pareteum Corporation
    37th Floor
    NY 10036 New York
    1185 Avenue Of The Americas
    United States
    02 oct 2018
    37th Floor
    NY 10036 New York
    1185 Avenue Of The Americas
    United States
    No
    Forma jurídicaCorporation
    País de registroUnited States
    Autoridad legalState Of Delaware
    Lugar de registroU.S. Securities And Exchange Commission
    Número de registro0001084384
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ARTILIUM GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 25 abr 2022
    Entregado el 16 may 2022
    Pendiente
    Breve descripción
    All intellectual property under, in relation to and as described in the “arta” document set out in the appendix to the security instrument. For full details of the charge, please refer to the document directly.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Circles Mvne Pte. LTD. as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Security Instrument)
    Transacciones
    • 16 may 2022Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 19 mar 2019
    Entregado el 29 mar 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    None.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Post Road Special Opportunity Fund I LP
    • Post Road Administrative LLP
    Transacciones
    • 29 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    • 16 oct 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2019
    Entregado el 08 mar 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Intellectual property - see schedule 3. arta mvne platform.
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Post Road Administrative Llc
    Transacciones
    • 08 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    • 02 jun 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2019
    Entregado el 08 mar 2019
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Post Road Administrative Llc
    Transacciones
    • 08 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    • 16 oct 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 26 feb 2019
    Entregado el 08 mar 2019
    Satisfecho en su totalidad
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Post Road Administrative Llc
    Transacciones
    • 08 mar 2019Registro de una carga (MR01)
    • 16 oct 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 ene 2012
    Entregado el 26 ene 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    700,000 euros due or to become due from the company
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hoving & Partners S.A.
    Transacciones
    • 26 ene 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 22 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 18 oct 2010
    Entregado el 03 nov 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    A sum of up to €3,300,000 due or to become due from the company to the noteholders and all other monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Hoving & Partners S.A.
    Transacciones
    • 03 nov 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 22 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creado el 24 ago 2006
    Entregado el 08 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A separate interest bearing designated business reserve account containing £70,481.00 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Derwent Valley London Limited
    Transacciones
    • 08 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 22 feb 2019Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 06 dic 2001
    Entregado el 19 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to and in accordance with the loan facility agreement dated 24TH july 2001 (as defined therein)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Antfactory Fit Holdco Limited
    Transacciones
    • 19 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over bank account
    Creado el 24 jul 2001
    Entregado el 27 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    All its rights, title and interest in: (a) (1) the sterling business account numbered 95115470 at the messrs C. hoare & co, (2) the business account, number 79278671 at national westminster bank PLC (3) the business reserve account, number 79278698 at national wetminster bank PLC.. (B) the balance from time to time on the charged accounts, including all interest, if any, accrued on the balance. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Antfactory Investments Bv
    Transacciones
    • 27 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 feb 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 24 jul 2001
    Entregado el 25 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the loan facility agreement dated 24 july 2001, the debenture or on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Antfactory Investments Bv
    Transacciones
    • 25 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 04 sept 2001Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 05 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0