MOORE ENGAGE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MOORE ENGAGE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03905153 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MOORE ENGAGE LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MOORE ENGAGE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Fountain Precinct 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MOORE ENGAGE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MOORE KINGSTON SMITH ADVISERS LIMITED | 09 sept 2019 | 09 sept 2019 |
| KINGSTON SMITH ADVISERS LIMITED | 23 ene 2006 | 23 ene 2006 |
| KINGSTON SMITH LIMITED | 12 ene 2000 | 12 ene 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MOORE ENGAGE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 abr 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 ene 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 abr 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MOORE ENGAGE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 28 sept 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 12 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 28 sept 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MOORE ENGAGE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Modification des détails de Moore Stephens Insight Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2026 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mrs Claudia Jane Dickinson el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Brian Anthony Mahon el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Fountain Precinct Balm Green Sheffield South Yorkshire S1 2JA England a Fountain Precinct 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green Sheffield S1 2JA el 11 mar 2026 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr Ross Graham el 02 mar 2026 | 1 páginas | CH03 | ||
Cambio de datos del director Mrs Hilary Anne Laing el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Peter Thomas Morley el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Fraser el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mrs Hilary Anne Laing el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Modification des détails de Moore Stephens Insight Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mar 2026 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mrs Claudia Jane Dickinson el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Peter Thomas Morley el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Fraser el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr Brian Anthony Mahon el 02 mar 2026 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Mr Ross Graham el 02 mar 2026 | 1 páginas | CH03 | ||
Domicilio social registrado cambiado de St James House Vicar Lane Sheffield S1 2EX United Kingdom a Fountain Precinct Balm Green Sheffield South Yorkshire S1 2JA el 02 mar 2026 | 1 páginas | AD01 | ||
Nombramiento de Mrs Claudia Jane Dickinson como director el 26 ene 2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2025 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Hilary Anne Laing como director el 01 abr 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Ross Graham como secretario el 27 ene 2025 | 2 páginas | AP03 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2024 | 7 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 28 sept 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Petra Rigelsford como secretario el 22 mar 2024 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2023 | 8 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de MOORE ENGAGE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAHAM, Ross | Secretario | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | 332015720001 | |||||||
| DICKINSON, Claudia Jane | Director | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | England | British | 338730830001 | |||||
| FRASER, Andrew John | Director | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | England | British | 317261030001 | |||||
| LAING, Hilary Anne | Director | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | United Kingdom | British | 158181690001 | |||||
| MAHON, Brian Anthony | Director | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | United Kingdom | British | 83567290006 | |||||
| MORLEY, Peter Thomas | Director | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | England | British | 230116770001 | |||||
| DEBENHAM, Malcolm John | Secretario | 9 Beacon Avenue LU6 2AD Dunstable Bedfordshire | British | 2860500001 | ||||||
| GILBERT, Leanne | Secretario | 24 Grove Vale BR7 5DS Chislehurst Kent | British | 103981500001 | ||||||
| RIGELSFORD, Petra | Secretario | Vicar Lane S1 2EX Sheffield St James House United Kingdom | 305238440001 | |||||||
| RIXON, Ian | Secretario | Vicar Lane S1 2EX Sheffield St James House United Kingdom | British | 62880150002 | ||||||
| TAYLOR, John Stuart Clifton | Secretario | 50 Tempest Mead North Weald CM16 6DY Epping Essex | British | 126524070001 | ||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||
| BROOKS, Nicholas St John | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 6414970001 | |||||
| BURCHMORE, Martin Arthur | Director | Skaraborg Shefford Mill Stanford Road SG17 5NR Shefford Bedfordshire | England | British | 5537510003 | |||||
| FARTHING, John | Director | 1 Cloisters Road SG6 3JR Letchworth Hertfordshire | England | British | 34499860003 | |||||
| FINLAYSON, Neil Michael | Director | Vicar Lane S1 2EX Sheffield St James House United Kingdom | United Kingdom | British | 142692410002 | |||||
| HOLT, Luke | Director | Vicar Lane S1 2EX Sheffield St James House United Kingdom | United Kingdom | British | 203570950003 | |||||
| JONES, Richard William | Director | Vicar Lane S1 2EX Sheffield St James House United Kingdom | England | British | 133585190001 | |||||
| MUIRHEAD, Martin Andrew | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 50900680001 | |||||
| NEAL, Steven | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 35558600003 | |||||
| NEWELL, James Christopher | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | England | British | 209013530001 | |||||
| PENFOLD, Maureen Bernadette | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 142692160001 | |||||
| SALWAY, Mark John | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 126523700002 | |||||
| SLINGER, Philip David Matthew | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | England | British | 209013540001 | |||||
| SNYDER, Michael John, Sir | Director | 60 Goswell Road EC1M 7AD London Devonshire House United Kingdom | England | British | 2860520004 | |||||
| TWUM-AMPOFO, Mark Kofi | Director | Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD | United Kingdom | British | 150322340001 | |||||
| WALSH, Julie Irene | Director | Woodside Cottage Sadlers End Sindlesham RG41 5AL Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104944230001 | |||||
| HALLMARK REGISTRARS LIMITED | Director designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004090001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MOORE ENGAGE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moore Stephens Insight Limited | 06 may 2022 | 4th Floor Orchard Lane Wing Balm Green S1 2JA Sheffield Fountain Precinct United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Devonshire Group Services Limited | 06 abr 2016 | 60 Goswell Road EC1M 7AD London Devonshire House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0