ASHCOURT NOMINEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ASHCOURT NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03915392 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | The Observatory Western Road RG12 1TL Bracknell Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 08 nov 2019 | 7 páginas | LIQ03 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a The Observatory Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 20 mar 2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Christopher Woodhouse como director el 24 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 58 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Wadham St. John Downing como director el 03 ago 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Lindop Hall como director el 30 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Woodhouse como director el 03 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Towry 6 New Street Square London EC4A 3BF England a 6 Chesterfield Gardens London England W1J 5BQ | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 04 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Robert Porteous como director el 28 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de C/O C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL England a C/O Rehana Hasan, Company Secretary Towry House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1TL el 02 nov 2016 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jacqueline Anne Gregory como secretario el 31 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Rehana Hasan como secretario el 31 oct 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Donald William Sherret Reid como director el 29 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Peter Lindop Hall como director el 29 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Alan Devey como director el 29 jul 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Vernon Wright como director el 30 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HASAN, Rehana | Secretario | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory Berkshire | 217662810001 | |||||||
| REID, Donald William Sherret | Director | Western Road RG12 1TL Bracknell The Observatory Berkshire | England | British | 212004930001 | |||||
| DUMERESQUE, Jane | Secretario | Harvest Hill House Burgess Hill Road Ansty RH17 5AH Haywards Heath West Sussex | British | 119657830001 | ||||||
| FLOWERS, Faye | Secretario | 13 Acott Fields Yalding ME18 6DQ Maidstone Kent | British | 97343720001 | ||||||
| GREGORY, Jacqueline Anne | Secretario | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | 197465000001 | |||||||
| HALE, Neil Andrew | Secretario | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UN West Malling Kent | British | 147690180001 | ||||||
| HALE, Neil Andrew | Secretario | 3 Malton Way TN2 4QE Tunbridge Wells Kent | British | 102820470001 | ||||||
| HASAN, Rehana | Secretario | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 Queen Victoria Street England | British | 174432770001 | ||||||
| HORTON, Marianne Carol | Secretario | 10 The Violets Paddock Wood TN12 6BH Tonbridge Kent | British | 82624080003 | ||||||
| PLATT, Valerie | Secretario | 28 Co Operative Street Hazel Grove SK7 4JN Stockport Cheshire | British | 63183690003 | ||||||
| ROWBURY, Timothy James | Secretario | 25 Priestley Drive Larkfield ME20 6TX Aylesford Kent | British | 79317290001 | ||||||
| TAGLIABUE, Alfio | Secretario | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UN West Malling Kent | British | 166867050001 | ||||||
| BRACHERS LIMITED | Secretario corporativo | Somerfield House, 59 London Road ME16 8JH Maidstone Kent | 80957680001 | |||||||
| BROWN, Christopher John Gordon | Director | Westwell St Michaels Drive Otford TN14 5SA Sevenoaks Kent | England | British | 51096850001 | |||||
| DEARING, Geoffrey Gordon | Director | Halfway Cottage Boughton Lane Boughton Monchelsea ME17 4ND Maidstone Kent | England | British | 2787210001 | |||||
| DEVEY, Robert Alan | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 146956760001 | |||||
| DOWNING, Wadham St. John | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 203301710001 | |||||
| FELSTEAD, Lisa June | Director | 100 Millbank Headcorn TN27 9RJ Ashford Kent | British | 91671410001 | ||||||
| HALE, Neil Andrew | Director | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UN West Malling Kent | United Kingdom | British | 66504200002 | |||||
| HALL, Peter Lindop | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 212005290001 | |||||
| HOLME, Christopher | Director | Power House The Street Sissinghurst TN17 2JL Cranbrook Kent | British | 35794640002 | ||||||
| MEREWEATHER, Ian Thomas | Director | 14 Paddock Close SP5 5NZ Sixpenny Handley Wiltshire | British | 97268250001 | ||||||
| MORTON, Alan John | Director | Thirty Acre Barn Shepherds Walk KT18 6BX Epsom Surrey | United Kingdom | British | 24658990005 | |||||
| OXLEY, Stephen Craig Kenneth | Director | Pipers Hill House Amport SP11 8AE Andover Hampshire | United Kingdom | British | 20003990001 | |||||
| PORTEOUS, John Robert | Director | c/o Rehana Hasan, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | England | British | 166212270001 | |||||
| RUSSELL, David Wallace | Director | Montgomery House Montgomery Road PO9 2RH Havant Hampshire | England | British | 62852230001 | |||||
| SMITH, Mark Anthony | Director | 11 Tower View Kings Hill ME19 4UN West Malling Kent | United Kingdom | British | 150721840002 | |||||
| SMITH, Mark Anthony | Director | 2 The Violets Paddock Wood TN12 6BH Tonbridge Kent | Uk | British | 102564660001 | |||||
| TAGLIABUE, Alfio | Director | Queen Victoria Street EC4N 4TR London 60 Queen Victoria Street England | United Kingdom | Italian | 76352220004 | |||||
| THORNTON JONES, Timothy | Director | Poundsbridge House Poundsbridge TN11 8AL Penshurst Kent | United Kingdom | British | 82270830001 | |||||
| TRAFFORD, James Anthony | Director | Nelson House Homington SP5 4NG Salisbury Wiltshire | England | British | 72794200001 | |||||
| WOODHOUSE, Christopher | Director | Chesterfield Gardens W1J 5BQ London 6 England England | England | British | 238888480001 | |||||
| WRIGHT, Paul Vernon | Director | c/o C/O Jacqui Gregory, Company Secretary Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House Berkshire England | United Kingdom | British | 137936580001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ASHCOURT NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashcourt Holdings Limited | 06 abr 2016 | Western Road RG12 1TL Bracknell Towry House England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ASHCOURT NOMINEES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0