LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED

LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaLEGEND COMMUNICATIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03923166
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    LEGEND COMMUNICATIONS PLC29 jul 200529 jul 2005
    BUSINESS SERVE PLC17 mar 200017 mar 2000
    NETWORK DIRECTIONS PLC10 feb 200010 feb 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital el 19 mar 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium account 19/03/2019
    RES13

    Nombramiento de Neil Andrew Wright como director el 01 oct 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Neil Colin Smith como director el 28 sept 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 09 oct 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2018

    16 páginasAA

    legacy

    228 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Andrew George Fraser May como director el 01 ene 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Alexander Henricus Lentink como director el 01 ene 2018

    2 páginasAP01

    Cuentas de subsidiaria exentas de auditoría preparadas hasta el 31 mar 2017

    16 páginasAA

    legacy

    224 páginasPARENT_ACC

    legacy

    2 páginasAGREEMENT2

    legacy

    3 páginasGUARANTEE2

    Declaración de confirmación presentada el 25 oct 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Nombramiento de Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017

    2 páginasAP02

    Cese del nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como director el 31 may 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    LENTINK, Alexander Henricus
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomDutch220206890001
    WRIGHT, Neil Andrew
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish155640160001
    VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2303594
    232519770001
    ASHWELL, John Harold
    33 Wharfdale Road
    N1 9SD London
    Secretario
    33 Wharfdale Road
    N1 9SD London
    British50508040002
    BARON, Christopher
    474 Leyland Lane
    PR25 1LA Leyland
    Lancs
    Secretario
    474 Leyland Lane
    PR25 1LA Leyland
    Lancs
    British109434090001
    HANSCOMB, Heledd Mair
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    Secretario
    63 Casewick Road
    SE27 0TB London
    British66806360001
    MACLEOD, David
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    Secretario
    12 Glebe Road
    Newton Mearns
    G77 6DU Glasgow
    British32696310001
    MOORE, Paul Anthony
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    152560920001
    SOUTHWART, Rachel
    3 Church Hill Avenue
    Warton
    LA5 9NU Carnforth
    Lancashire
    Secretario
    3 Church Hill Avenue
    Warton
    LA5 9NU Carnforth
    Lancashire
    British106623980001
    HALLMARK SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Secretario designado corporativo
    120 East Road
    N1 6AA London
    900004100001
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro2357692
    75473330004
    ALLAN, William
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    Director
    Shernfold Meadows
    Wadhurst Road
    TN3 9EH Frant
    East Sussex
    UkBritish111131550001
    ASHWELL, John Harold
    33 Wharfdale Road
    N1 9SD London
    Director
    33 Wharfdale Road
    N1 9SD London
    United KingdomBritish50508040002
    BAKER, Kenneth Wilfred, Rt Hon Lord
    Flat 6
    7 Onslow Gardens
    SW7 3LY South Kensington
    London
    Director
    Flat 6
    7 Onslow Gardens
    SW7 3LY South Kensington
    London
    United KingdomBritish77976620001
    BARON, Christopher
    474 Leyland Lane
    PR25 1LA Leyland
    Lancs
    Director
    474 Leyland Lane
    PR25 1LA Leyland
    Lancs
    British109434090001
    CLEAVER, Simon William
    Overtown Farm
    Woodman Lane, Cowan Bridge
    LA6 2HT Carnforth
    Director
    Overtown Farm
    Woodman Lane, Cowan Bridge
    LA6 2HT Carnforth
    British54116550006
    CRAWFORD, David William
    Paices Hill
    RG7 4PG Aldermaston
    Barn End House
    Berkshire
    Director
    Paices Hill
    RG7 4PG Aldermaston
    Barn End House
    Berkshire
    EnglandBritish315434370001
    DAVIS, Philip Stephen James
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Longshot Lane
    RG12 1XL Bracknell
    Waterside House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135958960001
    FORREST, Stuart
    Windy Ridge
    Wallings Lane, Silverdale
    LA5 0RZ Carnforth
    Lancashire
    Director
    Windy Ridge
    Wallings Lane, Silverdale
    LA5 0RZ Carnforth
    Lancashire
    British69452230004
    HALLAM, Mark Gerrard
    Cove Road
    Silverdale
    LA5 0QS Carnforth
    Hawthorn Bank
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Cove Road
    Silverdale
    LA5 0QS Carnforth
    Hawthorn Bank
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish139478650001
    HIGGINSON, Martin James
    Hay Carr
    Ellel
    LA2 0HJ Lancaster
    Lancashire
    Director
    Hay Carr
    Ellel
    LA2 0HJ Lancaster
    Lancashire
    EnglandBritish154448310001
    HOLT, Carl Eric
    Burkes Cottage
    2 Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Director
    Burkes Cottage
    2 Burkes Crescent
    HP9 1PD Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British68037820005
    JONES, Keith
    1 Higginsfield Mews
    SY14 8HE Cholomondeley
    Cheshire
    Director
    1 Higginsfield Mews
    SY14 8HE Cholomondeley
    Cheshire
    British99802500001
    KIMBERLEE, Andrew
    342 Ombersley Road
    WR3 7HE Worcester
    Director
    342 Ombersley Road
    WR3 7HE Worcester
    EnglandBritish86857590002
    LAPPING, Andrew Christopher
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    Director
    Hindley House
    Hindley Estate
    NE43 7SA Stocksfield
    Northumberland
    United KingdomBritish113467730001
    LONGTON, Timothy
    Wellstones 24 Tanyard Road
    Oakes
    HD3 4YW Huddersfield
    West Yorkshire
    Director
    Wellstones 24 Tanyard Road
    Oakes
    HD3 4YW Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish83295640001
    MAGUIRE, John Noel
    Silver Birch
    Sandy Lane, Ivy Hatch
    TN15 0PB Sevenoaks
    Kent
    Director
    Silver Birch
    Sandy Lane, Ivy Hatch
    TN15 0PB Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish169410600001
    MALE, Philip Stewart
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FL London
    39 Princess Park Manor
    Director
    Royal Drive
    Friern Barnet
    N11 3FL London
    39 Princess Park Manor
    United KingdomBritish112888290003
    MAY, Andrew George Fraser
    House
    Longshot Lane
    RG12 1WB Bracknell
    Waterside
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    House
    Longshot Lane
    RG12 1WB Bracknell
    Waterside
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish134139330002
    MOLZ, Martin
    5 Redvers Street
    LA1 5EA Lancaster
    Lancashire
    Director
    5 Redvers Street
    LA1 5EA Lancaster
    Lancashire
    American74969300001
    PHILLIP, Kerry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish185033430001
    SEEMANN, Mark Jonathan Kineret
    1 Sutton Lane
    Market Bosworth
    CV13 0LB Nuneaton
    Warwickshire
    Director
    1 Sutton Lane
    Market Bosworth
    CV13 0LB Nuneaton
    Warwickshire
    British45089940003
    SHOWELL, Steven David
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    EnglandBritish288289680002
    SMITH, Neil Colin
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United KingdomBritish204358750001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    1-2 Berkeley Square
    99 Berkeley Street
    G3 7HR Glasgow
    Berkeley Square
    Scotland
    06 abr 2016
    1-2 Berkeley Square
    99 Berkeley Street
    G3 7HR Glasgow
    Berkeley Square
    Scotland
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc192666
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene LEGEND COMMUNICATIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge of deposit
    Creado el 25 may 2004
    Entregado el 11 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The deposit of £400,000 credited to account designation 10188418 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 11 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 19 nov 2003
    Entregado el 28 nov 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the group company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Nigel Wadsworth and Andrew Hawksworth
    Transacciones
    • 28 nov 2003Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 oct 2001
    Entregado el 18 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 01 ago 2000
    Entregado el 16 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement of even date
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Hamilton Portfolio Limitedas Security Trustee for the Investors
    Transacciones
    • 16 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 dic 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 17 mar 2000
    Entregado el 25 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Nine thousand seven hundred pounds (9,750.00) due or to become due fr om the company to the chargee
    Breve descripción
    Monies held pursuant to the rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Martins Properties (Chelsea) Limited
    Transacciones
    • 25 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 17 mar 2000
    Entregado el 25 mar 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Seventeen thousand one hundred pounds (17,100.00) due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Monies held pursuant to the rent deposit deed.
    Personas con derecho
    • Martins Properties (Chelsea) Limited
    Transacciones
    • 25 mar 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0