SNTL REALISATIONS 2011 LTD

SNTL REALISATIONS 2011 LTD

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSNTL REALISATIONS 2011 LTD
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03924648
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    • (2852) /
    • (7487) /

    ¿Dónde se encuentra SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Dirección de la sede social
    Kpmg Llp PO BOX 695 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SANTIA LTD01 dic 201001 dic 2010
    CONNAUGHT COMPLIANCE LIMITED29 ene 200729 ene 2007
    CONNAUGHT R B S LTD21 ago 200221 ago 2002
    CONNAUGHT PROPERTY SERVICES (RBS) LTD24 dic 200124 dic 2001
    RETAIL BUILDING SERVICES LIMITED14 feb 200014 feb 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 06 ago 2013

    34 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 09 ago 2013

    34 páginas2.35B

    Informe de progreso del administrador hasta 25 may 2013

    36 páginas2.24B

    Aviso de nombramiento de administrador suplente/adicional

    1 páginas2.40B

    Aviso de vacante de oficina por el administrador

    33 páginas2.39B

    Informe de progreso del administrador hasta 25 nov 2012

    40 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 25 may 2012

    37 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 13 dic 2011

    36 páginas2.24B

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 13 ago 2011

    43 páginas2.24B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    11 páginas2.16B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    56 páginas2.17B

    Cese del nombramiento de Ian Carlisle como director

    2 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de Santia House Caerphilly Business Park Caerphilly Mid Glamorgan CF83 3GG Wales el 23 feb 2011

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Misceláneos

    Certificate of fact - name correction from sntl realisations LTD to sntl realisations 2011 LTD
    1 páginasMISC

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed santia LTD\certificate issued on 09/02/11
    4 páginasCERTNM
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 ene 2011

    RES15
    Anotaciones
    FechaAnotación
    10 feb 2011Other CHANGED ITS NAME ON 9TH FEBRUARY 2011 LTD TO SNTL REALISATIONS 2011 LTD AND NOT THE NAME SNTL REALISATIONS LTD AS INCORRECTLY SHOWN ON THE FACE OF THE CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME ISSUED ON THAT DATE.

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Cese del nombramiento de Julia Cavanagh como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Julia Cavanagh como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SNTL REALISATIONS 2011 LTD?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146809540001
    LUXON, Gail Corrine
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Secretario
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    British46661570001
    MATTHEWS, Samantha Louise
    3 Boundary Way
    BA6 9PJ Glastonbury
    Somerset
    Secretario
    3 Boundary Way
    BA6 9PJ Glastonbury
    Somerset
    British68772020001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Secretario
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Secretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Secretario
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    WALSH, Robert Daniel
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    Secretario
    Vine Cottage
    76 Carlingcott
    BA2 8AP Peasedown St John
    Bath
    British60752980001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secretario designado corporativo
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    ALDEN, Jeffrey Stephen Denton
    4 Ryeworth Road
    Charlton Kings
    GL52 6LH Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    4 Ryeworth Road
    Charlton Kings
    GL52 6LH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish100615010001
    BRAY, Iain Richard
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford-Upon-Avon
    198
    Warwickshire
    United Kingdom
    Director
    Banbury Road
    CV37 7HX Stratford-Upon-Avon
    198
    Warwickshire
    United Kingdom
    EnglandBritish154064760001
    BROWN, Paul John
    21 Beech Close
    Meadow Park
    EX15 2SD Willand
    Devon
    Director
    21 Beech Close
    Meadow Park
    EX15 2SD Willand
    Devon
    EnglandBritish183591260001
    CARLISLE, Ian
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp PO BOX 695 8
    Director
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Kpmg Llp PO BOX 695 8
    EnglandBritish146715900001
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    Director
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    United KingdomBritish140133020001
    DARBY SHIRE, Ian
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    Director
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    British101620840001
    DAVIES, Mark Dingad
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    Director
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish203044250004
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Director
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritish115233060001
    LUXON, Gail Corrine
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Director
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    United KingdomBritish46661570001
    LUXON, Michael John
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    Director
    The Round Pond
    Shipham Road
    BS27 3DD Cheddar
    Somerset
    United KingdomBritish34313080001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Director
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritish96786510001
    QUINN, Derek Anthony
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    Director
    26 Effingham Road
    St Andrews
    BS6 5BJ Bristol
    British72848250001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    Director
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Director
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritish104366980002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Director designado corporativo
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    ¿Tiene SNTL REALISATIONS 2011 LTD alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Mortgage of shares
    Creado el 06 ago 2009
    Entregado el 25 ago 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 ago 2009Registro de un cargo (395)
    Security agreement
    Creado el 06 ago 2009
    Entregado el 25 ago 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transacciones
    • 25 ago 2009Registro de un cargo (395)
    • 08 oct 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Security agreement
    Creado el 10 jul 2009
    Entregado el 23 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 jul 2009Registro de un cargo (395)
    • 08 oct 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Mortgage of shares
    Creado el 10 jul 2009
    Entregado el 23 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transacciones
    • 23 jul 2009Registro de un cargo (395)
    Mortgage of shares
    Creado el 21 may 2009
    Entregado el 28 may 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of a first equitable mortgage all the shares and by way of a first fixed charge its interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 28 may 2009Registro de un cargo (395)
    A mortgage of shares agreement
    Creado el 09 nov 2007
    Entregado el 28 nov 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first equitable mortgage all the shares and by way of a first fixed charge its interest in the shares (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Securitytrustee)
    Transacciones
    • 28 nov 2007Registro de un cargo (395)
    A security agreement
    Creado el 17 ago 2007
    Entregado el 31 ago 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transacciones
    • 31 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 oct 2010Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Guarantee & debenture
    Creado el 13 dic 2006
    Entregado el 16 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 16 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 may 2004
    Entregado el 20 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 20 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 29 jun 2001
    Entregado el 04 jul 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 jul 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creado el 06 jul 2000
    Entregado el 14 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 14 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 23 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 15 jun 2000
    Entregado el 29 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 29 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 04 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene SNTL REALISATIONS 2011 LTD algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 feb 2011Inicio de la administración
    09 ago 2013Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard John Hill
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Richard Heis
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    Profesional
    Kpmg Corporate Recovery
    P O Box 695
    EC4Y 8BB 8 Salisbury Square
    London
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0