SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03927500 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
- Intermediación financiera no clasificada en otra parte (64999) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | 2 Triton Square Regent's Place NW1 3AN London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GE CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED | 25 sept 2003 | 25 sept 2003 |
| IGROUP COMMERCIAL LIMITED | 20 sept 2000 | 20 sept 2000 |
| IGROUP SECURITIES LIMITED | 05 jun 2000 | 05 jun 2000 |
| MHAL 3 LIMITED | 27 mar 2000 | 27 mar 2000 |
| IGROUP3 LIMITED | 11 feb 2000 | 11 feb 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 oct 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 oct 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 oct 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Gerald John Davies como director el 16 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Jeremy Hall como director el 16 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 32 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen David Affleck como director el 21 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Lee Thomas Grant como director el 21 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Richard Tebboth como director el 30 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Francis Eugene Armour como director el 30 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen David Affleck como director el 31 dic 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Rachel Jane Morrison como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2020 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2019 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2018 | 15 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificaci ón de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom |
| 171739990001 | ||||||||||
| DAVIES, Gerald John | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | England | British | 330449420001 | |||||||||
| GRANT, Lee Thomas | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 312322560001 | |||||||||
| TEBBOTH, James Richard | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 285892290001 | |||||||||
| CASWELL, Sarah Anne | Secretario | 95 Rennie Court 11 Upper Ground SE1 9NZ London | British | 88740160002 | ||||||||||
| GREEN, Peter Harvey | Secretario | 7 Lower Park Road CH4 7BB Chester Cheshire | British | 123086060001 | ||||||||||
| HAYES, Daniel Edward Laurence | Secretario | Alpine Cottage 6 Old Brandon Lane Shadwell LS17 8HP Leeds Yorkshire | British | 78253650001 | ||||||||||
| OWENS, Jennifer Anne | Secretario | Flat A 55 Agate Road W6 0AL London | British | 113688770001 | ||||||||||
| SHAH, Kalpna | Secretario | 18 Vicarage Road WD18 0EH Watford Hertfordshire | British | 80753870001 | ||||||||||
| ABBEY NATIONAL NOMINEES LIMITED | Secretario corporativo | 2 Triton Square Regents Place NW1 3AN London Abbey National House | 135683020001 | |||||||||||
| RUTLAND NOMINEES (NO 2) LIMITED | Secretario corporativo | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham West Midlands | 73037780001 | |||||||||||
| RUTLAND SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Rutland House 148 Edmund Street B3 2JR Birmingham | 38851450001 | |||||||||||
| AFFLECK, Stephen David | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 213797030002 | |||||||||
| AINSWORTH, Keith | Director | 76 Howes Lane Finham CV3 6PJ Coventry Warwickshire | England | British | 46161840001 | |||||||||
| ARMOUR, Francis Eugene | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | England | British | 249033120001 | |||||||||
| ATTAR-ZADEH, Reza | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 185062240001 | |||||||||
| BRENNAN, Peter | Director | 10 Ardross Avenue HA6 3DS Northwood Middlesex | British | 84912240001 | ||||||||||
| CAMERON, Ewan Douglas | Director | 13 Heathfield Gardens W4 4JU London | British | 122900270001 | ||||||||||
| COOPER, Brad John | Director | Unit 507 Butlers Wharf Shad Thames SE1 2YE London | Australian | 85624150002 | ||||||||||
| CRICHTON, Susan Elizabeth | Director | The Pheasantries Ley Hill HP5 3QR Chesham Buckinghamshire | England | British | 69358970001 | |||||||||
| DEANE JOHNS, Simon Joshua | Director | 61 Stanlake Road W12 7HG London | Australian | 80748330001 | ||||||||||
| DEBOER, John Michiel | Director | Homefarm Harewood Park LS17 9LF Leeds | American | 122959330001 | ||||||||||
| DLUTOWSKI, Joseph Arthur | Director | 13127 Silver Fox Lane Palm Beach Gardens Palm Beach County 33418 United States Of America | American | 66506120001 | ||||||||||
| GIBSON, Callum Hamish | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | England | British | 162427510001 | |||||||||
| GREEN, David Martin | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | United Kingdom | British | 157202700001 | |||||||||
| HALL, Matthew Jeremy | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 91082690001 | |||||||||
| HARVEY, Richard John | Director | 6 Heronsford West Hunsbury NN4 9XG Northampton Northamptonshire | British | 122892160001 | ||||||||||
| KAGAN, Jeffrey Allan | Director | 14 Norrice Lea N2 0RE London | Australian | 78535300001 | ||||||||||
| LEVINE, Daniel Marsh | Director | 21a Kensington Church Street W8 4LF London | American | 123332770001 | ||||||||||
| LOVERING, Roger Vincent | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 | England | British | 28922470001 | |||||||||
| MACPHAIL, John Stewart | Director | 50 Stratton Road HP27 9AX Princes Risborough Buckinghamshire | British | 79593020002 | ||||||||||
| MATHEWSON, Alan | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 124568830004 | |||||||||
| MORRISON, Rachel Jane | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | England | British | 79351960007 | |||||||||
| MUSSERT, Adam Nicholas | Director | Triton Square Regents Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | United Kingdom | British | 174240260001 | |||||||||
| MUSSERT, Adam Nicholas | Director | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | British | 135682210001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SANTANDER CONSUMER CREDIT SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Cards Uk Limited | 06 abr 2016 | Triton Square Regent's Place NW1 3AN London 2 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0