CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03933031 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Rossington's Business Park West Carr Road DN22 7SW Retford Nottinghamshire England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CITYNET RESOURCES LIMITED | 24 feb 2000 | 24 feb 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2027 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 may 2027 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 abr 2026 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2026 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ryan Christopher Brown como director el 15 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 32 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Frankie Mccague como director el 21 dic 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Satwir Singh Rana el 22 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Mark Walsh el 22 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Adrian Colosso el 21 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Roy John Clark el 21 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Ryan Christopher Brown el 20 nov 2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy John Chadwick como director el 21 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Satwir Singh Rana como director el 15 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Mark Johnson como director el 30 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joanne Payne como director el 13 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 30 páginas | AA | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 32 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Roy John Clark como director el 01 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David James Winkett como director el 08 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Brendan James Mcmanus como director el 20 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 24 feb 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Brendan James Mcmanus el 18 jul 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy John Chadwick el 27 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARK, Roy John | Director | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London Pib Group Limited England England | United Kingdom | British | 141291090002 | |||||
| COLOSSO, Adrian | Director | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London Pib Group Limited England England | England | British | 4555310002 | |||||
| MCCAGUE, Frankie | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | Ireland | Irish | 330613320001 | |||||
| RANA, Satwir Singh | Director | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London Pib Group Limited England England | England | British | 328251700001 | |||||
| WALSH, Andrew Mark | Director | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London Pib Group Limited England England | England | British | 194692810002 | |||||
| STEVENSON, Christopher Burnett | Secretario | 16 Evelyn Gardens TW9 2PL Richmond Surrey | British | 37699300001 | ||||||
| WALLAND, David | Secretario | High Road Orsett RM16 3LD Grays 109 Essex England | British | 124608710001 | ||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| ANDREWS, Fiona | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | England | British | 264342050001 | |||||
| BROOKE, Timothy Tracy | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | England | British | 166626820003 | |||||
| BROWN, Ryan Christopher | Director | 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London Pib Group Limited England England | United Kingdom | British | 287066760001 | |||||
| CAMPION, William Philip | Director | 175 Old Church Road Chingford E4 6RB London | United Kingdom | Irish | 75245190001 | |||||
| CHADWICK, Timothy John | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | England | British | 192340400002 | |||||
| CHARMAN, Sacha John | Director | Ground Floor 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | United Kingdom | British | 179701190001 | |||||
| COOK, Nicholas James | Director | 111 The Avenue Highams Park E4 9RX London | British | 101257960001 | ||||||
| HICKS, Tim | Director | Ground Floor 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | England | English | 193401240001 | |||||
| JOHNSON, Paul Mark | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | England | British | 213094470001 | |||||
| KELLIHER, Patrick Joseph | Director | 27 Rosebery Avenue KT3 4JR New Malden Surrey | England | Irish | 97647660001 | |||||
| KINSELLA, Gerard Thomas | Director | Woodside Avenue KT10 8JQ Esher 31 Surrey | England | Irish | 89945710001 | |||||
| MCMANUS, Brendan James | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 128122260002 | |||||
| MITCHENALL, Grant Warren | Director | 40 Barrington Drive UB9 6RL Harefield Middlesex | British | 89682660001 | ||||||
| PAYNE, Joanne | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 293466220001 | |||||
| PENNINGTON LEGH, Peter Russell | Director | Vasterne Manor Wootton Bassett SN4 7PB Swindon Wiltshire | England | British | 42158460004 | |||||
| PURVES, Anthony Martin | Director | Raymond Road SL6 6DF Maidenhead 37 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 173108510001 | |||||
| REASON, Andrew Michael | Director | Ground Floor 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | England | English | 174621990002 | |||||
| SATCHWELL, John Patrick | Director | Springwell House Yalding Hill ME19 6AN Yalding Kent | England | British | 70133580002 | |||||
| SCOTT, Richard John | Director | York Road CM2 0AH Chelmsford 3 Essex United Kingdom | England | British | 80043340004 | |||||
| SEELEY, Richard John | Director | Ground Floor 71 Fenchurch Street EC3M 4BS London 71 England | England | British | 180654950001 | |||||
| SIMEONI, Marcus James | Director | 55 Wychford Drive CM21 0HA Sawbridgeworth Hertfordshire | British | 89682610001 | ||||||
| WALLAND, David | Director | High Road Orsett RM16 3LD Grays 109 Essex England | England | British | 124608710002 | |||||
| WEEDY, Melanie Jane | Director | 15 Willowdene Court Warley CM14 5ET Brentwood Essex | British | 89945820002 | ||||||
| WINKETT, David James | Director | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | United Kingdom | British | 73175560004 | |||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CITYNET INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pib Group Limited | 16 dic 2017 | 68 Lombard Street EC3V 9LJ London 5th Floor United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Richard John Scott | 06 abr 2016 | 68 Lombard Street EC3V 9LJ London 5th Floor United Kingdom | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Citynet London Holdings Limited | 06 abr 2016 | West Carr Road DN22 7SW Retford Rossington's Business Park Nottinghamshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0