CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03953915 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
- Compraventa de bienes inmobiliarios propios (68100) / Actividades inmobiliarias
- Otro alquiler y explotación de bienes inmobiliarios propios o arrendados (68209) / Actividades inmobiliarias
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
Dirección de la sede social | 180 Great Portland Street W1W 5QZ London United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 43-45 Portman Square London W1H 6LY a 180 Great Portland Street London W1W 5QZ el 03 dic 2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Alexander Edward Compton Hare el 12 jul 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 17 mar 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Mark Greenslade como director el 17 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Andrew Tatford como director el 17 mar 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Daniel Mark Greenslade como director el 13 ene 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 13 ene 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Frances Victoria Heazell como secretario el 07 dic 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Daniel Mark Greenslade como director el 07 dic 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Geoffrey Carter como director el 07 dic 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Alexander Edward Compton Hare como director el 05 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como secretario el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sandra Judith Odell como director el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2017 au 31 dic 2016 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 3 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 3 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 3 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 17 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Maxwell David Shaw James como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEAZELL, Frances Victoria | Secretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 220149250001 | |||||||
HARE, Alexander Edward Compton, Mr | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 215786330002 | ||||
TATFORD, Simon Andrew | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Tax | 228195340001 | ||||
DIXON, Susan Elizabeth | Secretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
EASTWOOD, Charlotte Ind | Secretario | 16 Edna Street SW11 3DP London | British | 50099790003 | ||||||
ODELL, Sandra Judith | Secretario | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | 174832560001 | |||||||
ROBSON SKEETE, Gail | Secretario | 22a Woodpecker Copse Locks Heath SO31 6WS Southampton Hampshire | British | Accountant | 66939460001 | |||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Secretario | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | British | Accountant | 130493170001 | |||||
EPS SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 184444990001 | ||||
DUGDALE, Edward Stratford | Director | Tickwood Hall TF13 6NZ Much Wenlock Shropshire | England | British | Company Director | 35942980003 | ||||
DWYER, Tonianne | Director | 170 Bishops Road Fulham SW6 7JG London | United Kingdom | Australian | Property Fund Manager | 94124780001 | ||||
GAVAGHAN, David Nicholas | Director | Grosvenor Street W1K 4QF London 16 | United Kingdom | British | Fund Manager | 151855940001 | ||||
GREENSLADE, Daniel Mark | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 196504990001 | ||||
GREENSLADE, Daniel Mark | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 196504990001 | ||||
HAMILTON STUBBER, James Robert | Director | 1 The Regency Hide Place SW1P 4HD London | United Kingdom | British | Director | 84913850002 | ||||
JAMES, Maxwell David Shaw | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 164108510002 | ||||
ODELL, Sandra Judith | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 132142980001 | ||||
RILEY, Michael Edward | Director | Tylers Barn Tylers Green Broad Street RH17 5DX Cuckfield West Sussex | British | Chartered Surveyor | 94724020002 | |||||
SHATTOCK, Nicholas Simon Keith | Director | 1 Court Lane Dulwich SE21 7DH London | England | British | Solicitor | 43632680001 | ||||
STEARN, Richard James | Director | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 94050800002 | ||||
WORTHINGTON, Rebecca Jane | Director | The Old Cottage 97 The High Street RG10 8DD Wargrave Berkshire | England | British | Accountant | 130493170001 | ||||
WYATT, Adrian Roger | Director | Broom Manor Cottered SG9 9QE Buntingford Hertfordshire | England | British | Company Director | 42858810002 | ||||
MIKJON LIMITED | Director corporativo | Lacon House 84 Theobald's Road WC1X 8RW London | 72341560001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English & Overseas Properties Limited | 06 abr 2016 | Portman Square W1H 6LY London 43-45 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene CHESTERFIELD (NO.6) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creado el 22 oct 2007 Entregado el 25 oct 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security agreement | Creado el 09 jun 2004 Entregado el 15 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Security agreement | Creado el 02 jun 2004 Entregado el 04 jun 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0