UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 03958461 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
- Transporte por tuberías (49500) / Transporte y almacenamiento
¿Dónde se encuentra UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Synergy House Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CHOIRCLOSE LIMITED | 28 mar 2000 | 28 mar 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 dic 2018 au 30 jun 2019 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Energy House Woolpit Business Park Woolpit Bury St Edmunds Suffolk IP30 9UP a Synergy House Windmill Avenue Woolpit Bury St. Edmunds IP30 9UP el 19 jun 2019 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Notification de Buuk Infrastructure No 2 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de The Gas Transportation Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 mar 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon John Lee como secretario el 17 jun 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2013 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Neil Shaw como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Clive Eric Linsdell el 23 oct 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Darryl John Corney como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012 | 11 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUMFORD, Christopher | Secretario | Ellen Street CF10 4BP Cardiff Driscoll 2 | British | 177345530001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Director | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Synergy House England | England | British | 83564940010 | |||||
| LINSDELL, Clive Eric | Director | Energy House Woolpit Business Park IP30 9UP Woolpit Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | 175552240002 | |||||
| LARGENT, Barry Roy | Secretario | Lavender Cottage The Street Rickinghall IP22 1EG Diss Norfolk | British | 108745880001 | ||||||
| LEE, Simon John | Secretario | Langham Place Highwoods CO4 9GB Colchester 7 Essex United Kingdom | British | 137019500001 | ||||||
| O'RIORDAN, William Gerard | Secretario | Shalom Curraclough Lissarda Cork Ireland | British | 70535680001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| CARR, Michael Derek | Director | Redstones Beacon Road TN6 3SX Crowborough Sussex | British | 28872750001 | ||||||
| CHARLTON, Philip | Director | 62 Quinta Drive Arkley EN5 3BE Barnet Hertfordshire | British | 145449850001 | ||||||
| FITZGERALD, Eugene Bernard | Director | Cloduv 2 Melbourn Road Bishopstown Cork Ireland | Irish | 92991480001 | ||||||
| GEOGHEGAN, Gerard | Director | 2 Claremont Pines IRISH Carrickmines Dublin 18 Ireland | Irish | 70535790001 | ||||||
| JEMMETT, Richard William | Director | 110 Northcott RG12 7WS Bracknell Berkshire | England | British | 68677410002 | |||||
| KENNA, Anthony Kevin | Director | 18 Pine Valley Drive Grange Road Dublin 16 Ireland | Irish | 70535940001 | ||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Director designado | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MORGAN, Dawn Caroline | Director | Energy House Woolpit Business Park IP30 9UP Woolpit Bury St Edmunds Suffolk | Uk | British | 105434660003 | |||||
| NICHOLSON, Thomas Edward | Director | 19 The Elms Stillorgan Road Donnybrook Dublin 4 Ireland | Irish | 70535860001 | ||||||
| PURCELL, David Colm | Director | 231 Crodaun Forrest Park IRISH Celbridge County Kildare Ireland | Irish | 70535720002 | ||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Director designado | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RICHARDS, Michael Roy | Director | Spruce Cottage Newbridge, Cadnam SO40 2NW Southampton Hampshire | England | British | 18060690002 | |||||
| SHAW, Neil Edward | Director | Woolpit Business Park Woolpit IP31 9UP Bury St. Edmunds Energy House Suffolk | United Kingdom | British | 107757420001 | |||||
| SPRUCE, Anthony | Director | Sans Pareil Rue Savage CHANNEL St Sampsons Guernsey | British | 26954450001 | ||||||
| WALSH, Robert Gerard | Director | Windsor Ovens, Co Cork Ireland | Irish | 104100510001 | ||||||
| WILSON, Francis Donald | Director | Middle Lodge Woodfold Park Preston New Road Mellor BB2 7NP Blackburn Lancs | England | British | 10721020001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Gas Transportation Company Limited | 06 abr 2016 | Admiral Park GY1 3HB St Peter Port Martello Court Guernsey Channel Islands | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Buuk Infrastructure No 2 Limited | 06 abr 2016 | Windmill Avenue Woolpit IP30 9UP Bury St. Edmunds Energy House Suffolk England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene UTILITY GRID INSTALLATIONS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security assignment | Creado el 30 ene 2007 Entregado el 06 feb 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from any obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción All of its right title and interest present and future in, under and to the contract meaning the intercompany loan agreement dated 28 april 2006. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0