BELL MICROPRODUCTS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BELL MICROPRODUCTS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03969946 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
- Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Dirección de la sede social | c/o AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD The Capitol Building Oldbury RG12 8FZ Bracknell Berkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
IDEAL HARDWARE LIMITED | 05 jun 2000 | 05 jun 2000 |
ALNERY NO. 1986 LIMITED | 11 abr 2000 | 11 abr 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 01 jul 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 7 páginas | MA | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 ago 2018
| 8 páginas | SH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 24 ago 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graeme Alistair Watt como director el 31 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Ryan Mccoy como director el 27 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 jul 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 jun 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Timothy Giles Willies como director el 08 sept 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Beate Reimann como director el 08 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cambio de datos del director Ms Beate Reimann el 01 nov 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jun 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 5 the Sterling Centre Eastern Road Bracknell Berkshire RG12 2PW a C/O Avnet Technology Solutions Ltd the Capitol Building Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8FZ el 14 oct 2014 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Russell Murdaugh como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILLIES, Timothy Giles | Director | c/o Avnet Europe - Legal Department Kouterveldstraat B-1831 Diegem 20 Belgium | England | British | Cfo Emea | 200807420001 | ||||
LEE, Nicholas James | Secretario | Cox Lane Chessington KT9 1SJ Surrey | British | 65430060002 | ||||||
LI, Jun | Secretario | Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | 153745890001 | |||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Secretario designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
BECHER WICKES, James Nicholas | Director | 65 Pelhams Walk KT10 8QA Esher Surrey | England | British | Director | 110374340001 | ||||
BELL, Walter Donald | Director | Cox Lane Chessington KT9 1SJ Surrey | Usa | American | President,Ceo | 71529540001 | ||||
BIRK, David Ralph, Mr. | Director | Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | Usa | American | Director | 136282980001 | ||||
BLANEY, Martin Robert Charles | Director | Montpellier House Templewood Park Templewood Lane SL2 4DA Stoke Poges Buckinghamshire | British | Director | 96133290001 | |||||
DIEU, Eric | Director | Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | Belgium | Belgian | Director | 153745750001 | ||||
FRENCH, Ian Michael | Director | 10 Davenant Road OX2 8BX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 29421010002 | ||||
ILLSON, James Elias | Director | 30 Mela Lane Rancho Palos Verde California 90275 Usa | American | Director | 98853750001 | |||||
LEE, Nicholas James | Director | Cox Lane Chessington KT9 1SJ Surrey | England | British | Director | 65430060002 | ||||
LEONG, Lawrence | Director | 633 Cheshire Way 94087 Sunnyvale California Usa | American | Executive Vice President | 71529570001 | |||||
LUNDY, Stephen Roy | Director | 1 Baden Drive RH6 8SD Horley Surrey | British | Director | 8062700001 | |||||
MCCOY, Michael Ryan, Mr. | Director | c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | United States | American | Legal Counsel | 187451430001 | ||||
MIESEGAES, Simon James Victor | Director | 14 Drakefield Road SW17 8RP London | British | Finance Director | 48740040002 | |||||
MILNER, Gordon | Director | Pilgrim Byre Pebble Hill Road RH6 7BW Betchworth Surrey | British | Sales Director | 65429910002 | |||||
MURDAUGH, Russell Raymond | Director | c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | Usa | American | Vp Finance | 174072910001 | ||||
REIMANN, Beate | Director | Avnet Europe Comm. Va - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | Belgium | German | Cfo | 183769070002 | ||||
RICHARD, Henri Pascal | Director | 13925 Mirmirou Drive 94022 Los Altos Ca Usa | American | President,Commercial Director | 71529510001 | |||||
SADOWSKI, Raymond John | Director | Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | Usa | American | Director | 143504560001 | ||||
TATHAM, Alexander Charles Heathcote | Director | 24 Kirkstall Road SW2 4HF London | British | Chartered Accountant | 69416350003 | |||||
TWOHIG, Seamus | Director | 80 Manor Road South Hinchley Wood KT10 0QQ Esher Surrey | Irish | Director | 67087660002 | |||||
WALKER, Mark | Director | Homelea Oakfield Road KT11 2LL Cobham Surrey | British | Director | 67087630001 | |||||
WATT, Graeme Alistair | Director | Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department Kouterveldstraat 20 B-1831 Diegem Eagle Building Belgium | England | British | Director | 25202730005 | ||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002920001 | |||||||
ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED | Director designado corporativo | 9 Cheapside EC2V 6AD London | 900002910001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenva Ts Holdings Limited | 06 abr 2016 | Oldbury RG12 8FZ Bracknell The Capitol Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene BELL MICROPRODUCTS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Legal mortgage | Creado el 09 mar 2007 Entregado el 13 mar 2007 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción F/H 2 crispin way haslingden rossendale lancashire t/n LA596977. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Supplemental deed relating to a syndicated composite guarantee and debenture dated 2 december 2002 | Creado el 19 jul 2004 Entregado el 30 jul 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of specific charge the equipment as follows; 1 x ups -U10100-30EUF fiskars 10000 series rated at 100KVA, 1 x commissioning ups, 1 x panasonic uf 788 laser fax serial no UFO788FAX, for details of further chattels charged, please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Syndicated composite guarantee and debenture | Creado el 02 dic 2002 Entregado el 13 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Unit 6A faraday ave. Hams hall distribution park coleshill birmingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
All assets debenture | Creado el 26 jun 2000 Entregado el 13 jul 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage debenture | Creado el 08 jun 2000 Entregado el 22 jun 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0