BELL MICROPRODUCTS LIMITED

BELL MICROPRODUCTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBELL MICROPRODUCTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03969946
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    • Otras actividades de servicios de tecnología de la información (62090) / Información y comunicación

    ¿Dónde se encuentra BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o AVNET TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
    The Capitol Building
    Oldbury
    RG12 8FZ Bracknell
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    IDEAL HARDWARE LIMITED05 jun 200005 jun 2000
    ALNERY NO. 1986 LIMITED11 abr 200011 abr 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta01 jul 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Memorándum y Estatutos

    7 páginasMA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 23 ago 2018

    • Capital: GBP 21,747,463
    8 páginasSH01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 24 ago 2018

    • Capital: GBP 1.0
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduction of the share premium account to nil 23/08/2018
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Graeme Alistair Watt como director el 31 ene 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 01 jul 2017

    7 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael Ryan Mccoy como director el 27 feb 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 02 jul 2016

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 abr 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 abr 2016

    Estado de capital el 14 abr 2016

    • Capital: GBP 5,226,463
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 27 jun 2015

    7 páginasAA

    Nombramiento de Mr Timothy Giles Willies como director el 08 sept 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Beate Reimann como director el 08 sept 2015

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 11 abr 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 abr 2015

    Estado de capital el 15 abr 2015

    • Capital: GBP 5,226,463
    SH01

    Cambio de datos del director Ms Beate Reimann el 01 nov 2014

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 jun 2014

    7 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de 5 the Sterling Centre Eastern Road Bracknell Berkshire RG12 2PW a C/O Avnet Technology Solutions Ltd the Capitol Building Oldbury Bracknell Berkshire RG12 8FZ el 14 oct 2014

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Russell Murdaugh como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILLIES, Timothy Giles
    c/o Avnet Europe - Legal Department
    Kouterveldstraat
    B-1831 Diegem
    20
    Belgium
    Director
    c/o Avnet Europe - Legal Department
    Kouterveldstraat
    B-1831 Diegem
    20
    Belgium
    EnglandBritishCfo Emea200807420001
    LEE, Nicholas James
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    Secretario
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    British65430060002
    LI, Jun
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Secretario
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    153745890001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secretario designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    BECHER WICKES, James Nicholas
    65 Pelhams Walk
    KT10 8QA Esher
    Surrey
    Director
    65 Pelhams Walk
    KT10 8QA Esher
    Surrey
    EnglandBritishDirector110374340001
    BELL, Walter Donald
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    Director
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    UsaAmericanPresident,Ceo71529540001
    BIRK, David Ralph, Mr.
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanDirector136282980001
    BLANEY, Martin Robert Charles
    Montpellier House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Stoke Poges
    Buckinghamshire
    Director
    Montpellier House
    Templewood Park Templewood Lane
    SL2 4DA Stoke Poges
    Buckinghamshire
    BritishDirector96133290001
    DIEU, Eric
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector153745750001
    FRENCH, Ian Michael
    10 Davenant Road
    OX2 8BX Oxford
    Oxfordshire
    Director
    10 Davenant Road
    OX2 8BX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector29421010002
    ILLSON, James Elias
    30 Mela Lane
    Rancho Palos Verde
    California 90275
    Usa
    Director
    30 Mela Lane
    Rancho Palos Verde
    California 90275
    Usa
    AmericanDirector98853750001
    LEE, Nicholas James
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    Director
    Cox Lane
    Chessington
    KT9 1SJ Surrey
    EnglandBritishDirector65430060002
    LEONG, Lawrence
    633 Cheshire Way
    94087 Sunnyvale
    California
    Usa
    Director
    633 Cheshire Way
    94087 Sunnyvale
    California
    Usa
    AmericanExecutive Vice President71529570001
    LUNDY, Stephen Roy
    1 Baden Drive
    RH6 8SD Horley
    Surrey
    Director
    1 Baden Drive
    RH6 8SD Horley
    Surrey
    BritishDirector8062700001
    MCCOY, Michael Ryan, Mr.
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    United StatesAmericanLegal Counsel187451430001
    MIESEGAES, Simon James Victor
    14 Drakefield Road
    SW17 8RP London
    Director
    14 Drakefield Road
    SW17 8RP London
    BritishFinance Director48740040002
    MILNER, Gordon
    Pilgrim Byre
    Pebble Hill Road
    RH6 7BW Betchworth
    Surrey
    Director
    Pilgrim Byre
    Pebble Hill Road
    RH6 7BW Betchworth
    Surrey
    BritishSales Director65429910002
    MURDAUGH, Russell Raymond
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    c/o Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanVp Finance174072910001
    REIMANN, Beate
    Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    Avnet Europe Comm. Va - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    BelgiumGermanCfo183769070002
    RICHARD, Henri Pascal
    13925 Mirmirou Drive
    94022 Los Altos
    Ca
    Usa
    Director
    13925 Mirmirou Drive
    94022 Los Altos
    Ca
    Usa
    AmericanPresident,Commercial Director71529510001
    SADOWSKI, Raymond John
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    UsaAmericanDirector143504560001
    TATHAM, Alexander Charles Heathcote
    24 Kirkstall Road
    SW2 4HF London
    Director
    24 Kirkstall Road
    SW2 4HF London
    BritishChartered Accountant69416350003
    TWOHIG, Seamus
    80 Manor Road South
    Hinchley Wood
    KT10 0QQ Esher
    Surrey
    Director
    80 Manor Road South
    Hinchley Wood
    KT10 0QQ Esher
    Surrey
    IrishDirector67087660002
    WALKER, Mark
    Homelea
    Oakfield Road
    KT11 2LL Cobham
    Surrey
    Director
    Homelea
    Oakfield Road
    KT11 2LL Cobham
    Surrey
    BritishDirector67087630001
    WATT, Graeme Alistair
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    Director
    Avnet Europe Comm. V.A - Legal Department
    Kouterveldstraat 20
    B-1831 Diegem
    Eagle Building
    Belgium
    EnglandBritishDirector25202730005
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Director designado corporativo
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de BELL MICROPRODUCTS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Tenva Ts Holdings Limited
    Oldbury
    RG12 8FZ Bracknell
    The Capitol Building
    England
    06 abr 2016
    Oldbury
    RG12 8FZ Bracknell
    The Capitol Building
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wale Companies Registry
    Número de registro3538262
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene BELL MICROPRODUCTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal mortgage
    Creado el 09 mar 2007
    Entregado el 13 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    F/H 2 crispin way haslingden rossendale lancashire t/n LA596977. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Supplemental deed relating to a syndicated composite guarantee and debenture dated 2 december 2002
    Creado el 19 jul 2004
    Entregado el 30 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of specific charge the equipment as follows; 1 x ups -U10100-30EUF fiskars 10000 series rated at 100KVA, 1 x commissioning ups, 1 x panasonic uf 788 laser fax serial no UFO788FAX, for details of further chattels charged, please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 30 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Syndicated composite guarantee and debenture
    Creado el 02 dic 2002
    Entregado el 13 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Unit 6A faraday ave. Hams hall distribution park coleshill birmingham. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of America, National Association
    Transacciones
    • 13 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    All assets debenture
    Creado el 26 jun 2000
    Entregado el 13 jul 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transacciones
    • 13 jul 2000Registro de un cargo (395)
    • 18 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 08 jun 2000
    Entregado el 22 jun 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 2000Registro de un cargo (395)
    • 18 dic 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0