HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 03977135 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Dirección de la sede social | 3rd Floor, South Building 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
LH(1) LIMITED | 14 abr 2000 | 14 abr 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 may 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 14 jun 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 may 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2023 | 15 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 19 may 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Saeed Hasan Mian como secretario el 10 may 2023 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Anastasija Blinova como secretario el 10 may 2023 | 1 páginas | TM02 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2022 | 15 páginas | AA | ||
Modification des détails de Cfs Newham Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 jul 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Modification des détails de Palio (No.4) Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 mar 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 05 may 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Rosemary Lucy Jude Deeley como director el 31 ene 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Dr Peter James Harding como director el 15 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Amit Rishi Jaysukh Thakrar como director el 15 oct 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Miss Rosemary Lucy Jude Deeley el 04 oct 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Harding como secretario el 30 sept 2021 | 1 páginas | TM02 | ||
Nombramiento de Miss Anastasija Blinova como secretario el 30 sept 2021 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 32 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Hannah Holman como director el 01 mar 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Daniel Marinus Maria Vermeer como director el 01 mar 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Harding como secretario el 10 jun 2020 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Cheryl Ward como secretario el 10 jun 2020 | 1 páginas | TM02 | ||
Cambio de datos del director Mr Amit Rishi Jaysukh Thakrar el 04 jun 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 14 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIAN, Saeed Hasan | Secretario | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | 309178620001 | |||||||
HARDING, Peter James, Dr | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | United Kingdom | British | Associate Director | 288230030001 | ||||
HOLMAN, Hannah | Director | Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor South, 200 England | United Kingdom | British | Director | 254825890001 | ||||
BLINOVA, Anastasija | Secretario | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | 287825230001 | |||||||
CURTIS, Richard Gregory | Secretario | 92 Beacons Park LD3 9BQ Brecon Powys | British | Secretary | 34503940003 | |||||
HARDING, Peter | Secretario | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | 270614530001 | |||||||
LEWIS, Maria | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | British | 152752020001 | ||||||
MIAN, Saeed Hasan | Secretario | 120 Aldersgate Street EC1A 4JQ London 5th Floor England | 254400250001 | |||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
MILLER, Roger Keith | Secretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
NAYLOR, Philip | Secretario | Kingsway WC2B 6AN London 1 | 201577020001 | |||||||
SHELL, Peter Geoffrey | Secretario | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||
THAKRAR, Amit Rishi Jaysukh | Secretario | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | 215581130001 | |||||||
WARD, Cheryl | Secretario | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | 258919570001 | |||||||
ASSET MANAGEMENT SOLUTIONS LIMITED | Secretario corporativo | 3rd Floor 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff South Glamorgan | 114724080001 | |||||||
BALLSDON, Andrew James | Director | 10 Fernbrook Road Caversham RG4 7HG Reading Berkshire | England | British | Chartered Accountant | 94560360001 | ||||
BARRITT, Gaynor | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | Uk | British | Operations Director | 156750560001 | ||||
BAYBUTT, Michael | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Operations Director- Hospitals | 74962840001 | ||||
BAYBUTT, Michael | Director | 33 Curtis Wood Park Road CT6 7TY Herne Bay Kent | United Kingdom | British | Operations Manager | 74962840001 | ||||
BERTHOU, Nicole | Director | 3/12-16 Billyard Avenue Elizabeth Bay Nsw 2011 Australia | Australian | Solutions Executive Private Ca | 101327730001 | |||||
BHUWANIA, Achal Prakash | Director | Welken House 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Equitix Limited England | England | British | Director | 202952390001 | ||||
CUTTANCE, Paul Francis | Director | 40 Priory Road TW9 3DH Richmond Surrey | Australian | Executive Manager Of Project & | 101327350001 | |||||
DEELEY, Rosemary Lucy Jude | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor, South Building England | England | British | Associate Director | 213533580001 | ||||
DIX, Carl Harvey | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Operations Director | 174290400002 | ||||
DIX, Carl Harvey | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Operations Director | 149134440001 | ||||
GRIFFIN, Joanne Jane | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | England | British | Senior Analyst | 180899770002 | ||||
HEATH, James Christopher | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 | United Kingdom | British | Director | 122413700002 | ||||
KEEVERS, Simon John | Director | 1 Bay Street Birchgrove Nsw 2041 Australia | Australian | Solutions Executive Private Ca | 101327480001 | |||||
LIAU, Andrew Samuel | Director | Flat 3 41 Carlton Drive SW15 2DG London | United Kingdom | Canadian | Investment Manager | 122624640004 | ||||
LUCAS, Gary Stephen | Director | 18 Willoughby Way Piddington NN7 2EH Northamptonshire | England | British | Associate Director | 70621740001 | ||||
MCDONALD, Angela Siobhan | Director | Saddleback Way GU51 2UR Fleet 1 Hampshire | England | British | Human Resources Manager | 109273410003 | ||||
MERCER-DEADMAN, Michael John | Director | Tennyson Road AL5 4BB Harpenden 18 Hertfordshire | Uk | British | General Manager, Investments | 10697910001 | ||||
MERCER-DEADMAN, Michael John | Director | 18 Tennyson Road AL5 4BB Harpenden Hertfordshire | Uk | British | General Manager Investments | 10697910001 | ||||
MILLS, Niall Patrick | Director | Finsbury Circus House 15 Finsbury Circus EC2M 7EB London 7f United Kingdom | United Kingdom | British | Asset Manager | 132740040001 | ||||
O'BRIEN, Kirsty | Director | 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Welken House England | Scotland | British | Operations Manager | 191923490001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cfs Newham Limited | 06 abr 2016 | Strathclyde Business Park ML4 3NJ Bellshill Avondale House Suite 1l-1o United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Palio (No 4) Limited | 06 abr 2016 | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 3rd Floor (South) United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene HEALTHCARE SUPPORT (NEWHAM) HOLDINGS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Creado el 30 ene 2004 Entregado el 11 feb 2004 | Pendiente | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción By way of first fixed charge all plant and machinery of the company by way of first fixed charge all land now being or in the future becoming the property of the company all the goodwill and uncalled capital intellectual property rights by way of floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0