BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED

BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBUTLER RESEARCH GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03984054
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SMALLBODY LIMITED02 may 200002 may 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 08 oct 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Reduction of share premium acc & cap redemption reserve 02/10/2014
    RES13

    Déclaration annuelle établie au 02 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Emily Louise Martin como secretario el 07 feb 2014

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Peter Stephen Rigby como director el 31 dic 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Adam Christopher Walker como director el 31 dic 2013

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2012

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Adam Christopher Walker el 01 mar 2013

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Emily Louise Martin el 03 ago 2012

    2 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 02 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    15 páginasAA

    Cambio de datos del director Rupert John Joseph Hopley el 01 mar 2012

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Rupert John Joseph Hopley como director el 01 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Rachel Elizabeth Jacobs como director el 16 sept 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John William Burton como director el 31 ago 2011

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Gareth Richard Wright el 19 ago 2011

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    14 páginasAA

    Nombramiento de Emily Louise Martin como secretario

    2 páginasAP03

    Déclaration annuelle établie au 02 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WOOLLARD, Julie Louise
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Secretario
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    British139159370002
    HOPLEY, Rupert John Joseph
    Zug
    Gubelstrasse 11
    6300
    Switzerland
    Director
    Zug
    Gubelstrasse 11
    6300
    Switzerland
    SwitzerlandBritishSolicitor164632060002
    WRIGHT, Gareth Richard
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritishAccountant131115190002
    BRADLEY, Stephen John
    Granary Cottage
    Mill Lane
    HU17 8QT Bishop Burton
    East Yorkshire
    Secretario
    Granary Cottage
    Mill Lane
    HU17 8QT Bishop Burton
    East Yorkshire
    BritishAccountant86702180001
    BUTLER SMITH, Stuart Michael Bruce
    18 Fielding Road
    W4 1HL London
    Secretario
    18 Fielding Road
    W4 1HL London
    BritishMarket Researcher67453450002
    DAYKIN, Michael Richard
    Weydon Hill Road
    GU9 8NZ Farnham
    94
    Surrey
    Secretario
    Weydon Hill Road
    GU9 8NZ Farnham
    94
    Surrey
    BritishChartered Accountant59323480003
    GILCHRIST, Andrew Iain
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    Secretario
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    BritishDirector89940590001
    MARTIN, Emily Louise
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    Secretario
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    United Kingdom
    160502750001
    MORROD, Jacqueline
    41 Hapenny Bridge Way
    HU9 1HD Hull
    North Humberside
    Secretario
    41 Hapenny Bridge Way
    HU9 1HD Hull
    North Humberside
    BritishFinancial Controller67130040001
    O'CONNELL, Kevin Francis
    135 Queens Road
    TW11 0LZ Teddington
    Middlesex
    Secretario
    135 Queens Road
    TW11 0LZ Teddington
    Middlesex
    Irish108189910001
    RICHMOND, Sonia Anna
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    Secretario
    8 Viscount Gardens
    KT14 6HE Byfleet
    Surrey
    British118535490002
    WARDEN, John Henderson
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    Secretario
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    BritishAccountant59501490001
    DATAMONITOR SECRETARIES LIMITED
    Charles House
    108-110 Finchley Road
    NW3 5JJ London
    Secretario corporativo
    Charles House
    108-110 Finchley Road
    NW3 5JJ London
    116374750001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    ANDERSON, John Edward
    20 Virginia Street
    Kensington
    FOREIGN New South Wales 2033 Australia
    Director
    20 Virginia Street
    Kensington
    FOREIGN New South Wales 2033 Australia
    AustralianDirector77080380001
    BECKER, Maximilian Nicolas Thomas Bibra
    14 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    Director
    14 Eagle Wharf
    138 Grosvenor Road
    SW1V 3JS London
    BritishDirector110699760001
    BURTON, John William
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Director
    Mortimer House
    37-41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    United KingdomBritishGeneral Counsel/Lawyer113684810001
    BUTLER, Martin Gordon
    Amblegales
    Sunny Mede Avenue
    HP5 3LE Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    Amblegales
    Sunny Mede Avenue
    HP5 3LE Chesham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director60292460003
    BUTLER SMITH, Stuart Michael Bruce
    18 Fielding Road
    W4 1HL London
    Director
    18 Fielding Road
    W4 1HL London
    BritishMarket Researcher67453450002
    DANSON, Michael Thomas
    Charles House 108-110 Finchley Road
    Swiss Cottage
    NW3 5JJ London
    Director
    Charles House 108-110 Finchley Road
    Swiss Cottage
    NW3 5JJ London
    BritishDirector16134990006
    FOYE, Anthony Martin
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    Director
    Lynwood
    White Lane
    RG26 5TN Hannington
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector99515780001
    GILBERTSON, David Stuart
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    Director
    Casa Maria
    Spaniard's End Hampstead
    NW3 7JG London
    United KingdomBritishDirector10921820004
    GILCHRIST, Andrew Iain
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    Director
    The Penthouse
    61 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    EnglandBritishDirector89940590001
    HARKNESS, Peter Martin
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    Director
    19 Horsley Court
    Montaigne Close Regency Street
    SW1 4BF London
    United KingdomBritishPublisher146757430001
    JACOBS, Rachel Elizabeth
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    United KingdomBritishCompany Secretary92334500004
    KERSWELL, Mark Henry
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    EnglandBritishDirector82609620003
    PYPER, Simon John
    56 Greenfield Gardens
    Golders Green
    NW2 1HY London
    Director
    56 Greenfield Gardens
    Golders Green
    NW2 1HY London
    BritishFinance Director108173190002
    RIGBY, Peter Stephen
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritishDirector69164290007
    WALKER, Adam Christopher
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    Director
    37/41 Mortimer Street
    W1T 3JH London
    Mortimer House
    England
    SwitzerlandBritishFinance Director129368430003
    WARDEN, John Henderson
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    Director
    Fairfield
    Silverdale Crescent
    S11 9JH Sheffield
    United KingdomBritishAccountant59501490001
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Director designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    ¿Tiene BUTLER RESEARCH GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignment of keyman life and critical illness policy
    Creado el 10 may 2004
    Entregado el 13 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policy being all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 10 may 2004
    Entregado el 13 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Assignment of key-man policy
    Creado el 03 may 2001
    Entregado el 23 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The policies and all monies thereby assured and the full benefit thereof; life assurance policy no.0090612235 Of legal and general assurance society dated 27/4/2001 in respect of m butler and m becker for £2,500,000.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 18 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 18 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 12 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (other than dividend on any shares)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Glavin Property Limited
    Transacciones
    • 12 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 11 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 11 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 09 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Maximillian Becker
    Transacciones
    • 09 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 17 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 06 abr 2001
    Entregado el 09 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Martin Butler
    Transacciones
    • 09 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 may 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0