BOND DORMANT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBOND DORMANT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 03995218
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BOND DORMANT LIMITED?

    • Alquiler y arrendamiento de equipo de transporte aéreo de pasajeros (77351) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra BOND DORMANT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gloucestershire Airport
    Staverton
    GL51 6SP Cheltenham
    Gloucestershire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BOND DORMANT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BOND EUROPEAN AVIATION LEASING LIMITED14 jul 200914 jul 2009
    BOND DORMANT COMPANY LIMITED12 abr 200812 abr 2008
    BOND AVIATION LEASING LIMITED11 may 200011 may 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BOND DORMANT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BOND DORMANT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Steven David Smith como director el 31 may 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven David Smith como secretario el 31 may 2013

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Arthur William Russell como director el 31 may 2013

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital05 jun 2013

    Estado de capital el 05 jun 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Steven David Smith el 05 nov 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Mr Steven David Smith el 05 nov 2012

    2 páginasCH03

    Cese del nombramiento de Geoffrey Bernard Williams como director el 13 jun 2012

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 8

    5 páginasMR04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    4 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Company business 19/04/2011
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    13 páginasAA

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2012 au 31 dic 2011

    1 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 11 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Stephen Bond como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Bond como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Bond como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Peter Bond como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    legacy

    3 páginasMG04

    ¿Quiénes son los directivos de BOND DORMANT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    RUSSELL, Arthur William
    Gloucestershire Airport
    Staverton
    GL51 6SP Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Gloucestershire Airport
    Staverton
    GL51 6SP Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandCanadianChief Financial Officer180792510001
    DWYER, Daniel John
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    Secretario designado
    6 Brimstone Close
    Chelsfield Park
    BR6 7ST Chelsfield
    Kent
    British900003970001
    LEACH, Michael Geoffrey
    13 Dynevor Road
    TW10 6PF Richmond
    Surrey
    Secretario
    13 Dynevor Road
    TW10 6PF Richmond
    Surrey
    BritishSolicitor26192670001
    SMITH, Steven David
    Park Place
    Park House West
    GL50 2RA Cheltenham
    50
    Gloucestershire
    England
    Secretario
    Park Place
    Park House West
    GL50 2RA Cheltenham
    50
    Gloucestershire
    England
    British65590120001
    BOND, Peter James
    Shipton Oliffe Manor
    Shipton Oliffe
    GL54 4HZ Andoversford
    Gloucestershire
    Director
    Shipton Oliffe Manor
    Shipton Oliffe
    GL54 4HZ Andoversford
    Gloucestershire
    EnglandBritishCompany Director51053350002
    BOND, Stephen William
    Rushbury House
    Winchcombe
    GL54 5AE Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Rushbury House
    Winchcombe
    GL54 5AE Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director77674640003
    DWYER, Daniel James
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    Director designado
    Fieldstock
    Vicarage Road
    DA5 2AW Bexley
    Kent
    British900019460001
    LARMAN, Trevor Ronald
    9 Hilltop Drive
    Westhill
    AB32 6PL Skene
    Aberdeenshire
    Director
    9 Hilltop Drive
    Westhill
    AB32 6PL Skene
    Aberdeenshire
    BritishManaging Director12839610001
    SMITH, Steven David
    Park Place
    Park House West
    GL50 2RA Cheltenham
    50
    Gloucestershire
    England
    Director
    Park Place
    Park House West
    GL50 2RA Cheltenham
    50
    Gloucestershire
    England
    United KingdomBritishAccountant65590120002
    WILLIAMS, Geoffrey Bernard
    Broadmead
    Haymes Drive Cleeve Hill
    GL52 3QQ Cheltenham
    Director
    Broadmead
    Haymes Drive Cleeve Hill
    GL52 3QQ Cheltenham
    UkBritishEngineer93247240002

    ¿Tiene BOND DORMANT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 28 abr 2011
    Entregado el 06 may 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any obligor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 06 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 30 may 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-sasb,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-ssxx,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-wmas,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-sasa,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-bzrs,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Aircraft mortgage dated 22 june 2007 and
    Creado el 27 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The aircraft; type EC135 T2 registration mark g-krnw,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2011Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    Security assignment
    Creado el 26 sept 2000
    Entregado el 11 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies liabilities and obligations due or to become due from the company to the chargee under or in connection with the aircraft hire purchase agreement dated 26 september 2000
    Breve descripción
    The rights, remedies title benefit and interest without limitation any rights to terminate the leasing of any of the aircraft referred to in the lease agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ge European Equipment Finance Limited
    Transacciones
    • 11 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0