YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC
Visión general
Nombre de la empresa | YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC |
---|---|
Estado de la empresa | Activa |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
Número de empresa | 03995784 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | No |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
- Actividades de consultoría de gestión que no sean gestión financiera (70229) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
- Actividades de consultoría ambiental (74901) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Dirección de la sede social | Units 8-9, Victoria Mills Stainland Road Greetland HX4 8AD Halifax West Yorkshire England |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
KIRKLEES ENERGY SERVICES CIC | 26 ene 2009 | 26 ene 2009 |
KIRKLEES ENERGY SERVICES | 12 may 2000 | 12 may 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Vencido | No |
---|---|
Próximas cuentas | |
Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
Últimas cuentas | |
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Última declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2025 |
---|---|
Próxima declaración de confirmación vence | 13 may 2025 |
Última declaración de confirmación | |
Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 29 abr 2024 |
Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Cuentas para una empresa mediana preparadas hasta el 31 mar 2024 | 51 páginas | AA | ||
Cancelación total de la carga 039957840002 | 1 páginas | MR04 | ||
Cancelación total de la carga 039957840003 | 1 páginas | MR04 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , Unit 1 Brookwoods Industrial Estate, Burrwood Way Holywell Green, Halifax, West Yorkshire, HX4 9BH a Units 8-9, Victoria Mills Stainland Road Greetland Halifax West Yorkshire HX4 8AD el 19 ago 2024 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Russell Sharman como director el 02 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Carol Margaret Hardy como director el 20 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 46 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mrs Diane Louise Swift como director el 02 nov 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 70 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr David George Titterton como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Janet Lesley Russell como director el 15 jun 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Robert Christopher Light como director el 01 may 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stephen David Cirell como director el 22 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Rowell Webber como director el 15 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 41 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Kenneth Michael Wood como director el 31 mar 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Keith Brian Watson como director el 01 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 51 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIGHT, Robert Christopher | Director | Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 England | United Kingdom | British | Non Executive Director | 112146410001 | ||||
MCCOMBIE, Duncan Scott | Director | Stainland Road Greetland HX4 8AD Halifax Units 8-9, Victoria Mills West Yorkshire England | England | British | Company Director | 145247440003 | ||||
SHARMAN, Peter Russell | Director | Stainland Road Greetland HX4 8AD Halifax Units 8-9, Victoria Mills West Yorkshire England | England | British | Non-Executive Director | 320238900001 | ||||
SWIFT, Diane Louise | Director | Stainland Road Greetland HX4 8AD Halifax Units 8-9, Victoria Mills West Yorkshire England | United Kingdom | British | Financial Director | 268240860001 | ||||
TITTERTON, David George | Director | Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1, Brookwoods Industrial Estate England | England | British | Director | 271294960001 | ||||
WATSON, Keith Brian | Director | Stainland Road Greetland HX4 8AD Halifax Units 8-9, Victoria Mills West Yorkshire England | United Kingdom | British | Director | 38294230002 | ||||
BYRNE, Ian William | Secretario | 17 Medland Woughton Park MK6 3BH Milton Keynes Buckinghamshire | British | 16504790001 | ||||||
ELLIS, Lynne | Secretario | 61 Gledholt Bank HD1 4HE Huddersfield | British | 75924380002 | ||||||
SLENEY, Amanda Sarah Louise | Secretario | Dean Brook Road Netherthong HD9 3UF Holmfirth Polly Dam England | British | Chartered Accountant | 120433310001 | |||||
SLENEY, Amanda Sarah Louise | Secretario | Upper Binns Cottage Binns Lane HD9 3BJ Holmfirth West Yorkshire | British | 120433310001 | ||||||
TURNER, John | Secretario | 45 Hall Park Avenue Crofton WF4 1LT Wakefield West Yorkshire | British | 42545780001 | ||||||
BEAL, James John | Director | The Gatehouse Castle Brewery Albert Street NG24 4AF Newark 29 Nottinghamshire | England | British | Project Manager | 96644050002 | ||||
BOLT, Stephen Martyn | Director | 112 Leeds Road WF14 0JE Mirfield West Yorkshire | England | British | Cleaning Contractor | 75924260001 | ||||
BOWEN, Joan Audrey | Director | 9 Stony Lane Honley HD7 2DY Huddersfield West Yorkshire | British | Retired | 70698770001 | |||||
BRICE, Tony, Councillor | Director | Belmont Close Highfield HD1 5DR Huddersfield 19 West Yorkshire | Great Britain | British | Cllr | 118753160001 | ||||
BYRNE, Ian William | Director | 17 Medland Woughton Park MK6 3BH Milton Keynes Buckinghamshire | England | British | Accountant | 16504790001 | ||||
CIRELL, Stephen David | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire | England | British | Solicitor | 141331620001 | ||||
CLEVELAND, Linda Francesca | Director | 9 Trenarle Drive BD16 4RE Shipley | British | Project Manager (Anchor) | 69936190001 | |||||
COOPER, Andrew Varah | Director | 76 Brockholes Lane Brockholes HD7 7AW Huddersfield West Yorkshire | England | United Kingdom | Local Govt Officer | 71199250001 | ||||
DAYNES, John | Director | 15 Greenacre Avenue Wyke BD12 9DE Bradford West Yorkshire | British | Business Sales | 76146440001 | |||||
DYSON, Michael John | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire England | England | British | Managing Director | 73151180001 | ||||
EDRICH, William Ramsey | Director | The Old Surgery 11 Chapel Street, Calverley LS28 5PS Pudsey W Yorkshire | England | British | Local Government Officer | 146484920001 | ||||
EDWARDS, Brian William, Professor | Director | 8 Foxglove Road Almondbury HD5 8LW Huddersfield | British | Professor Of Architecture | 69936210001 | |||||
FIRTH, Donald Malcolm, Councillor | Director | 34 Penistone Road New Mill HD9 7JP Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Electronics | 69646670001 | ||||
GRAHAM, Teresa Colomba | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire | England | British | Chartered Accountant | 85636480001 | ||||
GRANT, Richard Oswald Hill | Director | Two Oaks Bere Court Road RG8 8JY Pangbourne Berkshire | England | British | Lattice Group Head Of Envirome | 100433460001 | ||||
HARDY, Carol Margaret | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire | England | British | Director | 89078690001 | ||||
HERBERT, Andrew Charles | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire | England | British | Interim Manager | 133364270001 | ||||
LITTLEJOHNS, Sally Belinda | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire England | England | British | None | 167729090001 | ||||
LLOYD, David John | Director | The Hollies 112a Kaye Lane Almondbury HD5 8XU Huddersfield | British | Energy Water Consultant | 68466650001 | |||||
MCCABE, Vincent Michael | Director | Brookwoods Industrial Estate Burrwood Way Holywell Green HX4 9BH Halifax Unit 1 West Yorkshire England | England | British | Managing Director | 167849010001 | ||||
NICHOLLS, Richard | Director | 310 Den Lane Springhead OL4 4RE Oldham Lancashire | British | Senior University Lecturer | 80831050001 | |||||
NORTH, Gordon Garnet | Director | 1 Listing Drive Littletown WF15 6ER Liversedge West Yorkshire | England | British | Councillor | 69936230001 | ||||
OVER, John Lindsay | Director | Bramham House 80 Leeds Road Bramhope LS16 9BQ Leeds | British | Solicitor | 32594920001 | |||||
PAYNE, David Ronald | Director | 4 Wooldale Road HD9 1QN Holmfirth | England | British | Retired | 77661080001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para YORKSHIRE ENERGY SERVICES CIC?
Notificado el | Cesado el | Declaración |
---|---|---|
29 abr 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0