THE MIDSHIRES GROUP LIMITED

THE MIDSHIRES GROUP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE MIDSHIRES GROUP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04000460
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    • Otros servicios de alimentación (56290) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Apollo House Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Middlesex
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MIDSHIRES VENDING SERVICES LIMITED18 jul 200018 jul 2000
    DAILYCYBER LIMITED24 may 200024 may 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Consolidación de acciones el 19 oct 2017

    4 páginasSH02

    legacy

    3 páginasSH20

    Estado de capital el 20 oct 2017

    • Capital: GBP 1
    3 páginasSH19

    legacy

    3 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of capital redemption reserve 19/10/2017
    RES13
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Cancelación total de la carga 12

    4 páginasMR04

    Nombramiento de David Christophe Marc Flochel como director el 25 sept 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Wesley Mulligan como director el 25 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ghassan Nicolas Kara como director el 25 sept 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 09 may 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    10 páginasAA

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Charles Russell Speechlys Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX England a 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Dr Ghassan Nicolas Kara como director el 01 jul 2016

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Kris Paul Ludo Geysels como director el 01 jul 2016

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 09 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 may 2016

    Estado de capital el 23 may 2016

    • Capital: GBP 3,400,000
    SH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2015

    13 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de East Wing 14th Floor 389 Chiswick High Road Chiswick London W4 4AJ a Apollo House Odyssey Business Park West End Road Ruislip Middlesex HA4 6QD el 29 jul 2015

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 09 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital27 may 2015

    Estado de capital el 27 may 2015

    • Capital: GBP 3,400,000
    SH01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de C/O Speechly Bircham Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX England a C/O Charles Russell Speechlys Llp 6 New Street Square London EC4A 3LX

    1 páginasAD02

    Cese del nombramiento de Brian Robert Mackie como director el 18 dic 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Kris Paul Ludo Geysels como director el 18 dic 2014

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Director
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritishChartered Accountant183822370001
    FLOCHEL, David Christophe Marc
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    Director
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    SwitzerlandFrenchDirector238363320001
    MULLIGAN, Wesley
    Lime Tree Way
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    Spinnaker House
    England
    Director
    Lime Tree Way
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    Spinnaker House
    England
    EnglandIrishManaging Director238363000001
    GREENWOOD, Michael Frank
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Secretario
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    British163171480001
    HUSSEY, Paul Nicholas
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    Secretario
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    British28010290009
    PARRY, Michael David
    19 Westwood Drive
    SY3 8YB Shrewsbury
    Secretario
    19 Westwood Drive
    SY3 8YB Shrewsbury
    British36405300002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROTHERWOOD, Tony James
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    Director
    54 Frampton Grove
    Westcroft Park
    MK4 4GE Milton Keynes
    EnglandBritishDirector143546010001
    COLLIVER, Howard Francis
    30 Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Director
    30 Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    United KingdomBritishDirector39780590001
    CUNNINGHAM, James Alan
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    Director
    115 Broomwood Road
    SW11 6JU London
    United KingdomBritishDirector51864840002
    DOBBS, Neil Stoker
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    Director
    17 Elvaston Place
    SW7 5QF London
    United KingdomBritishDirector20511010001
    GARNER, Brian Stephen
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    Director
    Cornerways
    Kilpin Green
    MK16 9LZ North Crawley
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director27162650001
    GEYSELS, Kris Paul Ludo
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Director
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    BelgiumBelgianDirector193655140001
    GREEN, Mark Edward
    21 Vane Road
    SY3 7HB Shrewsbury
    Salop
    Director
    21 Vane Road
    SY3 7HB Shrewsbury
    Salop
    BritishOperations Director13230750001
    KARA, Ghassan Nicolas, Dr
    West End Road
    HA4 6DQ Ruislip
    Apollo House Odyssey Business Park
    Middlesex
    England
    Director
    West End Road
    HA4 6DQ Ruislip
    Apollo House Odyssey Business Park
    Middlesex
    England
    UkFrench/LebaneseCoo210351450001
    MACKIE, Brian Robert
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    ScotlandBritishDirector173446330002
    MACQUEEN, David Colin
    Crown House
    Meeting Street
    LE12 8EU Quorn
    Leicester
    Director
    Crown House
    Meeting Street
    LE12 8EU Quorn
    Leicester
    BritishCo Director3789860002
    MOONEY, Andrew John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    BritishDirector34345860005
    PARRY, Michael David
    19 Westwood Drive
    SY3 8YB Shrewsbury
    Director
    19 Westwood Drive
    SY3 8YB Shrewsbury
    United KingdomBritishFinancial Director36405300002
    ROE, Timothy Michael
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Director
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritishCompany Director Aca Bsc Hons51264250001
    STUBBS, Michael David
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7JT London
    Bunzl Plc
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director38305260002
    WHITELING, Mark Argent
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    Director
    389 Chiswick High Road
    Chiswick
    W4 4AJ London
    East Wing 14th Floor
    England
    EnglandBritishNone101297630001
    WILLIS, Helen Margaret
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    Director
    389 Chiswick High Road
    W4 4AJ Chiswick
    East Wing 14th Floor
    London
    United KingdomBritishDirector277089380001
    WYCHERLEY, Roland Edward
    Shires House
    Battlefield Park
    SY1 3JE Shrewsbury
    Salop
    Director
    Shires House
    Battlefield Park
    SY1 3JE Shrewsbury
    Salop
    BritishCompany Director62536790002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de THE MIDSHIRES GROUP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Provend Group Limited
    Odyssey Business Park, West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    06 abr 2016
    Odyssey Business Park, West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalLaws Of United Kingdom
    Lugar de registroCompanies House, England And Wales
    Número de registro03253929
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene THE MIDSHIRES GROUP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Fixed & floating security document
    Creado el 11 nov 2011
    Entregado el 01 dic 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Bnp Paribas (As Security Agent for Secured Parties)
    Transacciones
    • 01 dic 2011Registro de un cargo (MG01)
    • 11 oct 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property registered under t/no NN161766.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property registered under t/no LT98458.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property registered under t/no LT192337.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    F/H property registered under t/no LT88154.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 14 sept 2000
    Adquirido el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    L/H property under t/no LT192337.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de una adquisición (400)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 14 sept 2000
    Adquirido el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    F/H property registered under t/no LT98458.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de una adquisición (400)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 14 sept 2000
    Adquirido el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    F/H property under t/no LT88154.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de una adquisición (400)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 14 sept 2000
    Adquirido el 27 ene 2005
    Entregado el 04 feb 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    F/H property under t/no NN161766.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 04 feb 2005Registro de una adquisición (400)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Memorandum of deposit of stocks and shares
    Creado el 14 sept 2000
    Entregado el 27 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    1 "a" ordinary share of £1 each in the capital of darm limited; 500 ordinary shares of £1 each in the capital of shires vending services limited; 1,549,999 ordinary shares of £1 each in the capital of darm limited and all dividends interests rights moneys or property accruing.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 08 feb 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 sept 2000
    Entregado el 27 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0