ENRICHTECH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración de confirmación
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaENRICHTECH LIMITED
    Estado de la empresaLiquidación
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04005588
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ENRICHTECH LIMITED?

    • Restaurantes con licencia (56101) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
    • Pubs y bares (56302) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra ENRICHTECH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Jubilee House, Second Avenue
    Burton Upon Trent
    DE14 2WF Staffordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ENRICHTECH LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el11 ago 2022
    Próximas cuentas vencen el11 may 2023
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta15 ago 2021

    ¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ENRICHTECH LIMITED?

    Vencido
    Última declaración de confirmación cerrada hasta14 jun 2023
    Próxima declaración de confirmación vence28 jun 2023
    Última declaración de confirmación
    Próxima declaración de confirmación cerrada hasta14 jun 2022
    Vencido

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENRICHTECH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 26 mar 2024

    9 páginasLIQ03

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    4 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 27 mar 2023

    LRESSP

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Estado de capital el 09 mar 2023

    • Capital: GBP 1
    6 páginasSH19

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    2 páginasCAP-SS

    legacy

    2 páginasSH20

    Memorándum y Estatutos

    8 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Re: removal of various directors / appointment of director 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Derek Anthony Howell como director el 01 feb 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Peter Dando como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Edward Michael Bashforth como director el 01 feb 2023

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Francesca Appleby como secretario el 22 ago 2022

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 15 ago 2021

    5 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 16 ago 2020

    5 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 24 ago 2020 au 11 ago 2020

    1 páginasAA01

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 18 ago 2019

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2018

    4 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 19 ago 2017

    4 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ENRICHTECH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Director
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritishDirector299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627760001
    CLARKE, Emma Lynne
    5 River Avenue
    KT7 0RS Thames Ditton
    Surrey
    Secretario
    5 River Avenue
    KT7 0RS Thames Ditton
    Surrey
    British69597880001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488200001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secretario
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Secretario
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director23098320003
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Secretario
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    BritishAccountant51167890002
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161623810001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector55975990001
    HORROCKS, Madeleine Victoria
    Flat 1
    245 Stoke Newington Church Street
    N16 9HP London
    Director
    Flat 1
    245 Stoke Newington Church Street
    N16 9HP London
    BritishTrainee Solicitor71016710001
    KENNEDY, Samual Edward
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    Director
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive Officer149343140001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Director
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Director
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director23098320003
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    SNOOK, David Philip
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    Director
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    United KingdomBritishExecutive86850310001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Director
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    United KingdomBritishAccountant51167890002
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector128819260001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ENRICHTECH LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro5360893
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro4028125
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ENRICHTECH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    First ranking fixed and floating security document
    Creado el 08 dic 2006
    Entregado el 18 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transacciones
    • 18 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 25 abr 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 19 mar 2005
    Entregado el 01 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 01 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 23 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 02 may 2003
    Entregado el 09 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transacciones
    • 09 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 ago 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed supplemental to a composite guarantee and debenture dated 7TH august 2000
    Creado el 18 ago 2000
    Entregado el 21 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys and obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee (on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the secured documents) and to the finance parties by it or any other chargor under the secured documents (as defined)
    Breve descripción
    As described in the composite guarantee and debenture save that the title for site no 48 in the table for freehold properties shall be deleted and replaced with CH445871 and CH432365 and the title for site no 34 in the table for l/h properties shall be deleted and replaced with GM781708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 07 ago 2000
    Entregado el 21 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the royal bank of scotland PLC (as security trustee on behalf of itself and the banks and the financial institutions from time to time parties to the secured documents) under or pursuant to the secured documents (as defined) as the same may be amended,varied,novated,supplemented or replaced and this debenture
    Breve descripción
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 24 may 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ENRICHTECH LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 mar 2023Inicio de la liquidación
    21 mar 2023Fecha de la declaración de solvencia jurada
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Profesional
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0