DG INNOVATE PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | DG INNOVATE PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | 04006413 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de DG INNOVATE PLC?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra DG INNOVATE PLC?
| Dirección de la sede social | C/O GRANT THORNTON UK ADVISORY & TAX LLP 11th Floor, Landmark St Peter's Square, 1 Oxford Street M1 4PB Manchester |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de DG INNOVATE PLC?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PATH INVESTMENTS PLC | 20 feb 2016 | 20 feb 2016 |
| THE NICHE GROUP PLC | 28 nov 2000 | 28 nov 2000 |
| HALLCO 459 PLC | 02 jun 2000 | 02 jun 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de DG INNOVATE PLC?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para DG INNOVATE PLC?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jun 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 27 jun 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 13 jun 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para DG INNOVATE PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Peter Bardenfleth-Hansen como director el 04 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Frame Allardyce como director el 04 ago 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 15 Victoria Mews Cottingley Business Park Mill Field Road Bingley BD16 1PY England a 11th Floor, Landmark St Peter's Square, 1 Oxford Street Manchester M1 4PB el 09 may 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Declaración de asuntos | 85 páginas | LIQ02 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christian Fredrik Eidem como director el 06 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Carleton como director el 27 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Fallon como director el 27 feb 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Trevor Gabriel como director el 15 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Jochen Rudat como director el 15 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Comptes consolidés modifiés établis au 31 dic 2022 | 75 páginas | AAMD | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas George Selby Tulloch como director el 29 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Tierney como director el 29 ago 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Mark Carleton como director el 09 jul 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Sir Michael Fallon como director el 21 jun 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Hugh Boughtwood como director el 09 jun 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 09 may 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 19 abr 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 22 feb 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 88 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Renuncia del auditor | 3 páginas | AUD | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de DG INNOVATE PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY WILSON ACCOUNTING LTD | Secretario corporativo | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England |
| 269772200001 | ||||||||||
| PATEL, Rakesh Ramesh | Secretario | Cornwall Avenue N3 1LF London Aston House | 198445690001 | |||||||||||
| SUMNER, Bernard Michael | Secretario | 7 Chantlers Close RH19 1LU East Grinstead West Sussex | British | 41083480001 | ||||||||||
| CLIFFORD CLIFFORD & CO | Secretario corporativo | 2 Mansard Close HA5 3FQ Pinner Middlesex | 88917400001 | |||||||||||
| HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||||||
| KITWELL CONSULTANTS LIMITED | Secretario corporativo | The Warren WD7 7DU Radlett Kitwell House Hertfordshire |
| 90909530001 | ||||||||||
| ALLARDYCE, John Frame | Director | Oxford Street M1 4PB Manchester 11th Floor, Landmark St Peter's Square, 1 | United Kingdom | British | 272930290002 | |||||||||
| ASHFORD, Mark Thomas | Director | 3 New Court Place New Court Road CM2 6BW Chelmsford Essex | British | 81472770003 | ||||||||||
| BARDENFLETH-HANSEN, Peter | Director | Mill Field Road Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews Cottingley Business Park England | Denmark | Danish | 318801730001 | |||||||||
| BOUGHTWOOD, Andrew John | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 95780850002 | |||||||||
| BOUGHTWOOD, Martin Hugh | Director | Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews Cottingley Business Park United Kingdom | United Kingdom | British | 171186120002 | |||||||||
| BOYLAN, Donal Joseph | Director | Cornwall Avenue N3 1LF London Aston House | Ireland | Irish | 151579970001 | |||||||||
| CARLETON, Mark | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | Italy | American | 325057910001 | |||||||||
| CORRADO, Tommaso Maria | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 191090460001 | |||||||||
| DALTON, Stephen, Sir | Director | Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews Cottingley Business Park England | United Kingdom | British | 296910900001 | |||||||||
| DAVIS, Graeme Andrew | Director | 911 Green Lanes N21 2QP London | England | British | 36818550001 | |||||||||
| EIDEM, Christian Fredrik | Director | Mill Field Road Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews Cottingley Business Park England | Monaco | Norwegian | 318801220001 | |||||||||
| FALLON, Michael, Sir | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 324444110001 | |||||||||
| FITZPATRICK, Nigel Brent | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 117025710003 | |||||||||
| GABRIEL, Trevor | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | Monaco | British | 295065940001 | |||||||||
| GARSTON, Clive Richard | Director | Sandy Ridge Bollinway Hale WA15 0NZ Altrincham Cheshire | England | British | 12179600001 | |||||||||
| GREENSTONE, Nicolas David Antony | Director | Flat 19 Walham Court 109-111 Haverstock Hill NW3 4SD London | England | British | 3625600001 | |||||||||
| HARRIS, Raymond Ian | Director | 3 Golfside Close N20 0RD London | United Kingdom | British | 91547170001 | |||||||||
| LITTLE, Nigel Stuart | Director | Cornwall Avenue N3 1LF London Aston House | United Kingdom | British | 82118760001 | |||||||||
| NOLAN, Richard | Director | Cornwall Avenue N3 1LF London Aston House | England | Canadian | 162835100002 | |||||||||
| PATEL, Rakesh | Director | 41 Brookshill HA3 6RT Harrow Timbers Middlesex United Kingdom | United Kingdom | British | 27961710003 | |||||||||
| PATEL, Rakesh | Director | 10 East Hill HA9 9PT Wembley Park Middlesex | United Kingdom | British | 27961710002 | |||||||||
| PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Director | 17 Greenfield Drive Fortes Green N2 9AF London | England | British | 46176700002 | |||||||||
| RUDAT, Jochen | Director | Mill Field Road Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews Cottingley Business Park England | Germany | German | 318802140001 | |||||||||
| STAINFORTH, Christopher Graham | Director | Denfurlong House Lower Chedworth, Chedworth GL54 4AN Cheltenham Gloucestershire | England | British | 65268320001 | |||||||||
| STIRLING, Ronald Edward | Director | Woodland Lodge Spaniards End NW3 7JG London | England | British | 20434210003 | |||||||||
| SYMONDS, Patrick Bruce, Dr | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 157385220004 | |||||||||
| THEIS, Christopher Lorne Dennis Jonathan | Director | Cottingley Business Park Mill Field Road BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 174821380001 | |||||||||
| THOMAS, Stuart James | Director | Cornwall Avenue N3 1LF London Aston House | United Kingdom | British | 96729420001 | |||||||||
| TIERNEY, Peter | Director | Mill Field Road Cottingley Business Park BD16 1PY Bingley 15 Victoria Mews England | England | British | 132283210002 |
¿Tiene DG INNOVATE PLC algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA) |
| ||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidación voluntaria de acreedores |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0