PRECIS (1905) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPRECIS (1905) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04006951
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PRECIS (1905) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra PRECIS (1905) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    130 Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PRECIS (1905) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRECIS (1905) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    3 páginas4.71

    Cese del nombramiento de Freddy Achiel Bracke como director el 27 may 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. Franciscus Johannes Antonius Las como director el 27 may 2013

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de The Quadrangle 2nd Floor 180 Wardour Street London W1F 8LB el 14 mar 2013

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Clough Lane North Killingholme North Lincolnshire DN40 3LX el 07 ene 2013

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 17 dic 2012

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Joost Marc Edmond Rubens como director el 30 nov 2012

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Gary John Walker como director el 30 nov 2012

    2 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 jun 2012

    Estado de capital el 26 jun 2012

    • Capital: GBP 380,000
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Patricia Grout como secretario

    2 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2011

    15 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Patricia Ann Grout el 10 ene 2011

    3 páginasCH03

    Nombramiento de Freddy Achiel Bracke como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Exrealm Limited como director

    2 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 02 jun 2010 avec liste complète des actionnaires

    13 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Freddy Bracke como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PRECIS (1905) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    LAS, Franciscus Johannes Antonius
    Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    130
    Director
    Shaftesbury Avenue
    2nd Floor
    W1D 5EU London
    130
    NetherlandsDutchCompany Director178713940001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Secretario
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    British1367810004
    GROUT, Patricia Ann
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    Secretario
    Clough Lane
    North Killingholme
    DN40 3LX North Lincolnshire
    British126598200002
    HOLLOWAY, Mark Adrian
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    Secretario
    79 Cassiobury Drive
    WD1 3AG Watford
    Hertfordshire
    British60953190001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Secretario
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    BritishCompany Director62552110002
    NOLAN, Niall Joseph
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    Secretario
    14 Savona Close
    Wimbledon
    SW19 4HT London
    IrishCompany Director114924350001
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Secretario
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    BelgianDirector105595770001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Secretario designado corporativo
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOWDEN, Alwyn Keith
    244 Southport Road
    PR8 5LF Scarisbrick
    Southport
    Director
    244 Southport Road
    PR8 5LF Scarisbrick
    Southport
    BritishCompany Director57375500001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Director
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgianCompany Director147405030001
    BRACKE, Freddy Achiel
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Director
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    LuxembourgBelgianCompany Director147405030001
    CATT, Richard John
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    Director
    Avenings School Lane
    RH17 7JE Danehill
    West Sussex
    EnglandBritishLawyer1367810004
    CHADWICK, Timothy John Mackenzie
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    Director
    8 Clifton House
    Hollywood Road
    SW10 9XA London
    United KingdomBritishInvestment Banker119078580001
    CIGRANG, Christian Leon
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    Director
    Arthur Goemaerelei 24
    Antwerpen
    2018
    Belgium
    BelgiumBelgianCompany Director74484810001
    JOHNSTON, David Christopher, Dr
    Lodge Cottage Vale Royal
    Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    Director
    Lodge Cottage Vale Royal
    Whitegate
    CW8 2BA Northwich
    Cheshire
    BritishCivil Servant57375100001
    JOHNSTON, Wilfred Mark
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    Director
    Dalebrook House
    Baslow Road
    S42 7DD Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director107055750001
    KEANE, Adrian Spencer
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    Director
    Dale Acre Barn
    Main Street
    DE74 2RH Lockington
    Derby
    United KingdomBritishCompany Director62552110002
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Director
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director22018030002
    RUBENS, Joost Marc Edmond
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Director
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    BelgiumBelgianDirector134435140002
    VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    Director
    St Amandsstraat 95
    Strombeek-Bever
    B-1853
    Belgium
    BelgiumBelgianDirector105595770001
    WALKER, Gary John
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    Director
    Wardour Street
    W1F 8FY London
    The Quadrangle 180
    EnglandBritishCompany Director134900940001
    WALTMAIER, Brian
    21 Arbour Crescent
    SK10 2JB Macclesfield
    Cheshire
    Director
    21 Arbour Crescent
    SK10 2JB Macclesfield
    Cheshire
    BritishEngineer57374920001
    EXREALM LIMITED
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Director corporativo
    The Quadrangle 2nd Floor
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    65100670001
    MARITIME ADVISORY SERVICES LTD
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    Director corporativo
    The Quadrangle
    180 Wardour Street
    W1F 8FY London
    126598130001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Director designado corporativo
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    ¿Tiene PRECIS (1905) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 10 mar 2004
    Entregado el 19 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the principal borrower and each chargor and/or any other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC: Capital Markets (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 19 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission (relating to a composite guarantee and debenture dated 7 april 1997 as supplemented by deeds of admission dated 11 august 1998, 18 march 1999, 30 september 1999 and 24 december 1999)
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 06 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    See the mortgage charge document for full details. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Simon Group PLC
    Transacciones
    • 06 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of admission to composite guarantee and debenture dated 7 april 1997 as supplemented by deeds of admission dated 11 august 1998,18 march 1999, 30 september 1999 and 24 december 1999 (the "composite guarantee and debenture")
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 06 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all monies due or to become due from any existing company (as defined), the company or any relvant borrower (as defined) to the chargee on any account whatsoever (except for any money or liabilities due owing or incurred by any existing company or the charging company as guarantor for the charging company)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transacciones
    • 06 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2012Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene PRECIS (1905) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 feb 2014Fecha de disolución
    17 dic 2012Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Martin N Widdowson
    Brebner Allen & Trapp
    The Quadrangle
    W1F 8LB 180 Wardour Street
    London
    Profesional
    Brebner Allen & Trapp
    The Quadrangle
    W1F 8LB 180 Wardour Street
    London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0