PRECIS (1905) LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | PRECIS (1905) LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04006951 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PRECIS (1905) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra PRECIS (1905) LIMITED?
Dirección de la sede social | 130 Shaftesbury Avenue 2nd Floor W1D 5EU London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PRECIS (1905) LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRECIS (1905) LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros | 3 páginas | 4.71 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Freddy Achiel Bracke como director el 27 may 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Franciscus Johannes Antonius Las como director el 27 may 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de The Quadrangle 2nd Floor 180 Wardour Street London W1F 8LB el 14 mar 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Clough Lane North Killingholme North Lincolnshire DN40 3LX el 07 ene 2013 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de solvencia | 4 páginas | 4.70 | ||||||||||
Nombramiento de un liquidador voluntario | 2 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Joost Marc Edmond Rubens como director el 30 nov 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Gary John Walker como director el 30 nov 2012 | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | MG02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Patricia Grout como secretario | 2 páginas | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2011 | 15 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Patricia Ann Grout el 10 ene 2011 | 3 páginas | CH03 | ||||||||||
Nombramiento de Freddy Achiel Bracke como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Exrealm Limited como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 02 jun 2010 avec liste complète des actionnaires | 13 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Freddy Bracke como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PRECIS (1905) LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS, Franciscus Johannes Antonius | Director | Shaftesbury Avenue 2nd Floor W1D 5EU London 130 | Netherlands | Dutch | Company Director | 178713940001 | ||||
CATT, Richard John | Secretario | Avenings School Lane RH17 7JE Danehill West Sussex | British | 1367810004 | ||||||
GROUT, Patricia Ann | Secretario | Clough Lane North Killingholme DN40 3LX North Lincolnshire | British | 126598200002 | ||||||
HOLLOWAY, Mark Adrian | Secretario | 79 Cassiobury Drive WD1 3AG Watford Hertfordshire | British | 60953190001 | ||||||
KEANE, Adrian Spencer | Secretario | Dale Acre Barn Main Street DE74 2RH Lockington Derby | British | Company Director | 62552110002 | |||||
NOLAN, Niall Joseph | Secretario | 14 Savona Close Wimbledon SW19 4HT London | Irish | Company Director | 114924350001 | |||||
VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat | Secretario | St Amandsstraat 95 Strombeek-Bever B-1853 Belgium | Belgian | Director | 105595770001 | |||||
OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Level 1 Exchange House Primrose Stret EC2A 2HS London | 900019420001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BOWDEN, Alwyn Keith | Director | 244 Southport Road PR8 5LF Scarisbrick Southport | British | Company Director | 57375500001 | |||||
BRACKE, Freddy Achiel | Director | Wardour Street W1F 8FY London The Quadrangle 180 | Luxembourg | Belgian | Company Director | 147405030001 | ||||
BRACKE, Freddy Achiel | Director | Wardour Street W1F 8FY London The Quadrangle 180 | Luxembourg | Belgian | Company Director | 147405030001 | ||||
CATT, Richard John | Director | Avenings School Lane RH17 7JE Danehill West Sussex | England | British | Lawyer | 1367810004 | ||||
CHADWICK, Timothy John Mackenzie | Director | 8 Clifton House Hollywood Road SW10 9XA London | United Kingdom | British | Investment Banker | 119078580001 | ||||
CIGRANG, Christian Leon | Director | Arthur Goemaerelei 24 Antwerpen 2018 Belgium | Belgium | Belgian | Company Director | 74484810001 | ||||
JOHNSTON, David Christopher, Dr | Director | Lodge Cottage Vale Royal Whitegate CW8 2BA Northwich Cheshire | British | Civil Servant | 57375100001 | |||||
JOHNSTON, Wilfred Mark | Director | Dalebrook House Baslow Road S42 7DD Chesterfield Derbyshire | England | British | Company Director | 107055750001 | ||||
KEANE, Adrian Spencer | Director | Dale Acre Barn Main Street DE74 2RH Lockington Derby | United Kingdom | British | Company Director | 62552110002 | ||||
REDBURN, Timothy John | Director | Little Abbotts Snower Hill Road RH3 7AQ Betchworth Surrey | England | British | Company Director | 22018030002 | ||||
RUBENS, Joost Marc Edmond | Director | Wardour Street W1F 8FY London The Quadrangle 180 | Belgium | Belgian | Director | 134435140002 | ||||
VAN BELLINGEN, Frank Luc Renaat | Director | St Amandsstraat 95 Strombeek-Bever B-1853 Belgium | Belgium | Belgian | Director | 105595770001 | ||||
WALKER, Gary John | Director | Wardour Street W1F 8FY London The Quadrangle 180 | England | British | Company Director | 134900940001 | ||||
WALTMAIER, Brian | Director | 21 Arbour Crescent SK10 2JB Macclesfield Cheshire | British | Engineer | 57374920001 | |||||
EXREALM LIMITED | Director corporativo | The Quadrangle 2nd Floor 180 Wardour Street W1F 8FY London | 65100670001 | |||||||
MARITIME ADVISORY SERVICES LTD | Director corporativo | The Quadrangle 180 Wardour Street W1F 8FY London | 126598130001 | |||||||
PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Level 1 Exchange House Primrose Street EC2A 2HS London | 900019410001 |
¿Tiene PRECIS (1905) LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creado el 10 mar 2004 Entregado el 19 mar 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the principal borrower and each chargor and/or any other member of the group to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of admission (relating to a composite guarantee and debenture dated 7 april 1997 as supplemented by deeds of admission dated 11 august 1998, 18 march 1999, 30 september 1999 and 24 december 1999) | Creado el 22 sept 2000 Entregado el 06 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Breve descripción See the mortgage charge document for full details. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of admission to composite guarantee and debenture dated 7 april 1997 as supplemented by deeds of admission dated 11 august 1998,18 march 1999, 30 september 1999 and 24 december 1999 (the "composite guarantee and debenture") | Creado el 22 sept 2000 Entregado el 06 oct 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all monies due or to become due from any existing company (as defined), the company or any relvant borrower (as defined) to the chargee on any account whatsoever (except for any money or liabilities due owing or incurred by any existing company or the charging company as guarantor for the charging company) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene PRECIS (1905) LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0