RAKAD STOKE 1 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRAKAD STOKE 1 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04008612
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    West Court
    Campbell Road
    ST4 4FB Stoke-On-Trent
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    M.K.C. (HOLDINGS) LIMITED05 feb 200105 feb 2001
    LIMITDAILY LIMITED06 jun 200006 jun 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    5 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Sigma House Lakeside, Festival Park Stoke-on-Trent ST1 5RY England a West Court Campbell Road Stoke-on-Trent ST4 4FB el 30 abr 2021

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Notification de Gary Paul Williams en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC01

    Notification de Peter Davenport en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016

    2 páginasPSC01

    Declaración de confirmación presentada el 06 jun 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name06 dic 2016

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 30 nov 2016

    RES15

    Domicilio social registrado cambiado de Clarence House Clarence Road Longton Stoke-on-Trent ST3 1AZ a Sigma House Lakeside, Festival Park Stoke-on-Trent ST1 5RY el 06 dic 2016

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 6

    1 páginasMR04

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 24 nov 2016

    • Capital: GBP 300
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share premium account 22/11/2016
    RES13

    Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga 6

    2 páginasMR05

    Déclaration annuelle établie au 06 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital20 jun 2016

    Estado de capital el 20 jun 2016

    • Capital: GBP 300
    SH01

    ¿Quiénes son los directivos de RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BALL, Francis Jeffrey
    15 Riseley Road
    Hartshill
    ST4 6AU Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    15 Riseley Road
    Hartshill
    ST4 6AU Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish113783730001
    DAVENPORT, Peter
    Grange Park Drive
    Biddulph
    ST8 7XU Stoke-On-Trent
    Grange Cottage
    United Kingdom
    Director
    Grange Park Drive
    Biddulph
    ST8 7XU Stoke-On-Trent
    Grange Cottage
    United Kingdom
    EnglandBritish113783800008
    DAWSON, Richard Mark
    1 Fletcher Crescent
    Baddeley Green
    ST2 7AW Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    1 Fletcher Crescent
    Baddeley Green
    ST2 7AW Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish113783580001
    WILLIAMS, Gary Paul
    The Old Vicarage
    Church Road
    ST6 8TD Brown Edge
    Staffordshire
    Director
    The Old Vicarage
    Church Road
    ST6 8TD Brown Edge
    Staffordshire
    EnglandBritish113783650001
    ADAMS, Alfred Joseph, Mr.
    Chez Nous Clewlows Bank
    Stockton Brook
    ST9 9LN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secretario
    Chez Nous Clewlows Bank
    Stockton Brook
    ST9 9LN Stoke On Trent
    Staffordshire
    British10638540001
    BUXTON, Christopher Raymond
    51 Brampton Avenue
    SK10 3RH Macclesfield
    Cheshire
    Secretario
    51 Brampton Avenue
    SK10 3RH Macclesfield
    Cheshire
    British90835500001
    DAVENPORT, Peter
    12 Fieldview
    Halls Meadow
    ST8 6TQ Biddulph
    Staffordshire
    Secretario
    12 Fieldview
    Halls Meadow
    ST8 6TQ Biddulph
    Staffordshire
    British113783800001
    FLEETWOOD, Matthew David
    5 Woodland Avenue
    WA13 0BJ Lymm
    Cheshire
    Secretario
    5 Woodland Avenue
    WA13 0BJ Lymm
    Cheshire
    British67509880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Alfred Joseph, Mr.
    Chez Nous Clewlows Bank
    Stockton Brook
    ST9 9LN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    Chez Nous Clewlows Bank
    Stockton Brook
    ST9 9LN Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish10638540001
    ADAMS, Robert Anthony
    183 Bagnall Road
    Light Oaks
    ST2 7NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    183 Bagnall Road
    Light Oaks
    ST2 7NE Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish20193920001
    BEECH, David Andrew
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    Director
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    British141162490001
    BUXTON, Christopher Raymond
    51 Brampton Avenue
    SK10 3RH Macclesfield
    Cheshire
    Director
    51 Brampton Avenue
    SK10 3RH Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish90835500001
    FLEETWOOD, Matthew David
    5 Woodland Avenue
    WA13 0BJ Lymm
    Cheshire
    Director
    5 Woodland Avenue
    WA13 0BJ Lymm
    Cheshire
    British67509880001
    SMITH, Anthony Clifford
    131 Washerwall Lane
    Werrington
    ST9 0LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Director
    131 Washerwall Lane
    Werrington
    ST9 0LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    British20193940001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RAKAD STOKE 1 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Peter Davenport
    Campbell Road
    ST4 4FB Stoke-On-Trent
    West Court
    England
    06 abr 2016
    Campbell Road
    ST4 4FB Stoke-On-Trent
    West Court
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 50% pero no más del 75% de las acciones de la compañía.
    Mr Gary Paul Williams
    Campbell Road
    ST4 4FB Stoke-On-Trent
    West Court
    England
    06 abr 2016
    Campbell Road
    ST4 4FB Stoke-On-Trent
    West Court
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene RAKAD STOKE 1 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 mar 2012
    Entregado el 03 abr 2012
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2012Registro de un cargo (MG01)
    • 24 nov 2016Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 05 dic 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 jun 2006
    Entregado el 20 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee and the security beneficiaries) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Alfred Joseph Adams and Anthony Clifford Smith
    Transacciones
    • 20 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 jun 2006
    Entregado el 14 jun 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 14 jun 2006Registro de un cargo (395)
    • 21 oct 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 17 mar 2004
    Entregado el 18 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Land and buildings on the south west of dividy road bucknall, land on the south east of trent street bucknall and 42 dividy road bucknall stoke-on-trent. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 18 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 23 jun 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 27 may 2002
    Entregado el 30 may 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £500,000.00 due from the company to the chargee
    Breve descripción
    F/Hold property known as bridge industrial estate,hot lane,cobridge,stoke on trent with all fixtures,fittings and goodwill of business thereon; all interests,fixed plant and machinery and all rental deposits and guarantees; floating charge over. Undertaking and all property and assets.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 30 may 2002Registro de un cargo (395)
    • 12 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Legal charge
    Creado el 06 jun 2001
    Entregado el 13 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h land and buildings on the south west of dividy road bucknall.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 13 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 12 oct 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0