ABSOLUTE SWINDON LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | ABSOLUTE SWINDON LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04012403 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Dirección de la sede social | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
JLPBS SWINDON LIMITED | 27 jun 2000 | 27 jun 2000 |
INTERCEDE 1579 LIMITED | 12 jun 2000 | 12 jun 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin Dixon como director el 29 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 21 nov 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 may 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Bethan Melges el 16 jul 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Cambio de datos del secretario Mrs Bethan Melges el 16 jul 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Lee Howard como director el 01 jun 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair James Gordon-Stewart como director el 01 jun 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Alan Turner como director el 19 ene 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Bethan Melges como secretario el 16 jul 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Armitage como secretario el 16 jul 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Renuncia del auditor | 4 páginas | AUD | ||||||||||
Misceláneos Section 519 | 1 páginas | MISC | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 22 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Matthew Armitage como secretario el 22 dic 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELGES, Bethan | Secretario | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | 199664340001 | |||||||
HOWARD, Lee | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 208700940001 | ||||
THOMAS, Leigh Parry | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | United Kingdom | British | Business Space Development Director | 159413310001 | ||||
ARMITAGE, Matthew | Secretario | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | 193689100001 | |||||||
BOND, Christopher Joseph | Secretario | 22 George Street MK17 9PY Woburn Bedfordshire | British | 169680930001 | ||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Secretario | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | 161846380001 | |||||||
SMITH, David Ian | Secretario | 35 Wimbolt Street E2 7BX London | British | Solicitor | 5186170001 | |||||
WOODS, Ian Paul | Secretario | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | British | 3535740003 | ||||||
MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
ARDERN, Derrick | Director | Twyvidales 85 Eythrope Road HP17 8PH Stone Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 44478670001 | ||||
BAIN, Colin Ronald | Director | Orion Villa 63 Church Road DA7 4DL Bexleyheath Kent | United Kingdom | British | Project Manager | 89021130003 | ||||
BOND, Christopher Joseph | Director | 22 George Street MK17 9PY Woburn Bedfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 169680930001 | ||||
BRADLEY, Pauline Anne | Director | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | Solicitor | 122926460001 | |||||
BYRNE, James Anthony John | Director | 4 Blythe Way B91 3EY Solihull West Midlands | British | Director | 83499160001 | |||||
CUMMINGS, Peter Joseph | Director | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | Bank Official | 68241910003 | ||||
DIXON, Kevin | Director | Cavendish Place W1G 9NB London 6 England | England | British | Company Director | 41560840002 | ||||
DUNCOMBE, Roger John | Director | Croft House 16 Faircross Way AL1 4SD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Property Developer | 20158760001 | ||||
GILMAN, Thomas George | Director | 4 Court Barton Lane Clifford LS23 6SN Wetherby The Maples West Yorkshire England | England | British | Director | 159657830001 | ||||
GILMAN, Thomas George | Director | 70 High Street Clifford LS23 6HJ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 103084110001 | ||||
GORDON-STEWART, Alastair James | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | England | British | Finance Director | 124512200002 | ||||
LAMBERT, James Paul | Director | 2 Portman Avenue East Sheen SW14 8NX London | United Kingdom | British | Property Developer | 103062380001 | ||||
RICH, Michael William | Director | Hillfield Gorse Hill, Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | Solicitor | 70341190001 | |||||
ROBB, Gordon William | Director | 7 High Buckstone Fairmilehead EH10 6XS Edinburgh Midlothian | British | Accountant | 11456230001 | |||||
SIMKIN, Richard William | Director | 14 Little Plucketts Way IG9 5QU Buckhurst Hill Essex | England | British | Director | 13432460001 | ||||
TURNER, Nigel Alan, Mr. | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 71592210007 | ||||
WARNER, William | Director | 2 Honeysuckle Gardens CR0 8XU Croydon | British | Chartered Secretary | 62351120001 | |||||
WHITE, Andrew Nicholas Howard | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 99292200003 | ||||
WOODS, Ian Paul | Director | Tempsford Hall Sandy SG19 2BD Bedfordshire | England | British | Director | 3535740003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Property Limited | 06 abr 2016 | Sandy SG19 2BD Bedfordshire Tempsford Hall England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene ABSOLUTE SWINDON LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Supplemental debenture | Creado el 29 jul 2004 Entregado el 12 ago 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción L/H property 4 and 6 cavendish place london t/n NGL734622 by way of fixed charge all interests in the new property or the proceeds of sale, the benefit of all options easements agreements for lease and other agreements, all plant and machinery and all rights and interests of the company under all agreements for purchase maintenance or use of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 12 abr 2002 Entregado el 22 abr 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent or to each other beneficiary (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 30 abr 2001 Entregado el 17 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 01 feb 2001 Entregado el 07 feb 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Legal charge | Creado el 01 feb 2001 Entregado el 07 feb 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción The property k/a drakes meadow business park drakes way swindon t/n WT179143. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0