ABSOLUTE SWINDON LIMITED

ABSOLUTE SWINDON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaABSOLUTE SWINDON LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04012403
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    JLPBS SWINDON LIMITED27 jun 200027 jun 2000
    INTERCEDE 1579 LIMITED12 jun 200012 jun 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Kevin Dixon como director el 29 dic 2017

    1 páginasTM01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 21 nov 2017

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 22 may 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2016

    6 páginasAA

    Cambio de datos del secretario Mrs Bethan Melges el 16 jul 2015

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del secretario Mrs Bethan Melges el 16 jul 2015

    1 páginasCH03

    Déclaration annuelle établie au 22 may 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 jun 2016

    Estado de capital el 22 jun 2016

    • Capital: GBP 100,001
    SH01

    Nombramiento de Mr Lee Howard como director el 01 jun 2016

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Alastair James Gordon-Stewart como director el 01 jun 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015

    2 páginasAA

    Cese del nombramiento de Nigel Alan Turner como director el 19 ene 2016

    1 páginasTM01

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Nombramiento de Mrs Bethan Melges como secretario el 16 jul 2015

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Matthew Armitage como secretario el 16 jul 2015

    1 páginasTM02

    Renuncia del auditor

    4 páginasAUD

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Déclaration annuelle établie au 22 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 jun 2015

    Estado de capital el 12 jun 2015

    • Capital: GBP 100,001
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2014

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mr Matthew Armitage como secretario el 22 dic 2014

    2 páginasAP03

    ¿Quiénes son los directivos de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MELGES, Bethan
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Secretario
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    199664340001
    HOWARD, Lee
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    United KingdomBritishDirector208700940001
    THOMAS, Leigh Parry
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    United KingdomBritishBusiness Space Development Director159413310001
    ARMITAGE, Matthew
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Secretario
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    193689100001
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Secretario
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    British169680930001
    HAMILTON, Deborah Pamela
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Secretario
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    161846380001
    SMITH, David Ian
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    Secretario
    35 Wimbolt Street
    E2 7BX London
    BritishSolicitor5186170001
    WOODS, Ian Paul
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Secretario
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    British3535740003
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    ARDERN, Derrick
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Twyvidales
    85 Eythrope Road
    HP17 8PH Stone Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor44478670001
    BAIN, Colin Ronald
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    Director
    Orion Villa
    63 Church Road
    DA7 4DL Bexleyheath
    Kent
    United KingdomBritishProject Manager89021130003
    BOND, Christopher Joseph
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    Director
    22 George Street
    MK17 9PY Woburn
    Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor169680930001
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Director
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    BritishSolicitor122926460001
    BYRNE, James Anthony John
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    Director
    4 Blythe Way
    B91 3EY Solihull
    West Midlands
    BritishDirector83499160001
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Director
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritishBank Official68241910003
    DIXON, Kevin
    Cavendish Place
    W1G 9NB London
    6
    England
    Director
    Cavendish Place
    W1G 9NB London
    6
    England
    EnglandBritishCompany Director41560840002
    DUNCOMBE, Roger John
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Croft House
    16 Faircross Way
    AL1 4SD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishProperty Developer20158760001
    GILMAN, Thomas George
    4 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Wetherby
    The Maples
    West Yorkshire
    England
    Director
    4 Court Barton Lane
    Clifford
    LS23 6SN Wetherby
    The Maples
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector159657830001
    GILMAN, Thomas George
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    Director
    70 High Street
    Clifford
    LS23 6HJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor103084110001
    GORDON-STEWART, Alastair James
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritishFinance Director124512200002
    LAMBERT, James Paul
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    Director
    2 Portman Avenue
    East Sheen
    SW14 8NX London
    United KingdomBritishProperty Developer103062380001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Director
    Hillfield
    Gorse Hill, Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    BritishSolicitor70341190001
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Director
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    BritishAccountant11456230001
    SIMKIN, Richard William
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    Director
    14 Little Plucketts Way
    IG9 5QU Buckhurst Hill
    Essex
    EnglandBritishDirector13432460001
    TURNER, Nigel Alan, Mr.
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor71592210007
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Director
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    BritishChartered Secretary62351120001
    WHITE, Andrew Nicholas Howard
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor99292200003
    WOODS, Ian Paul
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Director
    Tempsford Hall
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    EnglandBritishDirector3535740003

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ABSOLUTE SWINDON LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Tempsford Hall
    England
    06 abr 2016
    Sandy
    SG19 2BD Bedfordshire
    Tempsford Hall
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroUnited Kingdom
    Número de registro3810395
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ABSOLUTE SWINDON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental debenture
    Creado el 29 jul 2004
    Entregado el 12 ago 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    L/H property 4 and 6 cavendish place london t/n NGL734622 by way of fixed charge all interests in the new property or the proceeds of sale, the benefit of all options easements agreements for lease and other agreements, all plant and machinery and all rights and interests of the company under all agreements for purchase maintenance or use of plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent and Trustee for Thebeneficiaries
    Transacciones
    • 12 ago 2004Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 12 abr 2002
    Entregado el 22 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security agent or to each other beneficiary (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 abr 2002Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2001
    Entregado el 17 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 17 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 01 feb 2001
    Entregado el 07 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 01 feb 2001
    Entregado el 07 feb 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a drakes meadow business park drakes way swindon t/n WT179143. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 2001Registro de un cargo (395)
    • 04 may 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0