EQUITON NOMINEE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EQUITON NOMINEE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04012435 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EQUITON NOMINEE LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Cunard House 15 Regent Street SW1Y 4LR London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| INTERCEDE 1582 LIMITED | 12 jun 2000 | 12 jun 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 6 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Anthony Redding como director el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Andrew John Pilsworth como director el 30 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Simon Christian Pursey como director el 30 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Ann Octavia Peters como director el 30 jun 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Andrew Carlyon como director el 30 jun 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gareth John Osborn el 20 ene 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gareth John Osborn el 15 nov 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Philip Anthony Redding el 06 feb 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alastair Hughes como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Clayton como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Cooper-Parry como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 31 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLEASE, Elizabeth Ann | Secretario | Cunard House 15 Regent Street SW1Y 4LR London | Other | 132060350001 | ||||||
| HOLLAND, Alan Michael | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | United Kingdom | British | 167815240001 | |||||
| OSBORN, Gareth John | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | England | British | 91257750004 | |||||
| PETERS, Ann Octavia | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House | England | British | 199465250001 | |||||
| PILSWORTH, Andrew John | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House | England | British | 155293090003 | |||||
| PURSEY, Simon Christian | Director | Bath Road SL1 4DX Slough 258 | United Kingdom | British | 190915460001 | |||||
| DIXON, Susan Elizabeth | Secretario | Flat 1 29-31 Dingley Place EC1 8BR London | British | 90007990001 | ||||||
| HOWELL, Richard | Secretario | Flat 7 Kilmeny House 36 Arterberry Road Wimbledon SW20 8AQ London | British | 164790590001 | ||||||
| SILVER, Helen Frances | Secretario | 68 Glenwood Gardens IG2 6XU Ilford Essex | British | 120878580001 | ||||||
| WATTS, Nigel Anthony | Secretario | 32 Springfield Park North Parade RH12 2BF Horsham West Sussex | British | 6864530001 | ||||||
| WHALLEY, Amanda | Secretario | 12 Merchant Court 61 Wapping Wall Wapping E1W 3SD London | British | 124348320001 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Secretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| YOUNG, Mark Lees | Secretario | 30 Southway Totteridge N20 8DB London | British | 85330350001 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| AGNEW, Julian Michael, Mr. | Director | 2 Blythwood Road N4 4EU Stroud Green London | England | British | 151724030001 | |||||
| ANDREWS, Michael John | Director | Elm Grove Road Ealing W5 3JJ London 14 | British | 98009700001 | ||||||
| BRIDGES, David Crawford | Director | Bath Road 234 Bath Road SL1 4EE Slough 234 Berkshire England | United Kingdom | British | 94982860002 | |||||
| CARLYON, Simon Andrew | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | United Kingdom | Australian | 158659290001 | |||||
| CLAYTON, Susan Vivien | Director | 11 Patten Road SW18 3RH London | England | British | 98599620001 | |||||
| COOPER-PARRY, Peter Roger | Director | 76 Lambton Road West Wimbledon SW20 0LP London | British | 64390460001 | ||||||
| DAWSON, Peter Allan | Director | 9 St James Close St Johns Wood NW8 7LG London | British | 64472530003 | ||||||
| HUGHES, Alastair | Director | 42 Achilles Road NW6 1EA London | British | 66863880001 | ||||||
| OWEN, Steven Jonathan | Director | Foxholes Farley Green GU5 9DN Albury Surrey | United Kingdom | British | 29079190002 | |||||
| REDDING, Philip Anthony | Director | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | England | British | 126099150003 | |||||
| RICH, Michael William | Director | Hillfield Gorse Hill, Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | 70341190001 | ||||||
| SIMMS, Vanessa Kate | Director | Bath Road 234 Bath Road . SL1 4EE Slough 234 . England | United Kingdom | British | 155054720002 | |||||
| WARNER, William | Director | 2 Honeysuckle Gardens CR0 8XU Croydon | British | 62351120001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EQUITON NOMINEE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equiton Gp Limited | 06 abr 2016 | 15 Regent Street SW1Y 4LR London Cunard House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EQUITON NOMINEE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement between,among others,the company and the agent (as defined) | Creado el 06 dic 2001 Entregado el 19 dic 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor (as defined) to each finance party (as defined) under each finance document (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0