VIZZAVI LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaVIZZAVI LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04017435
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de VIZZAVI LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra VIZZAVI LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de VIZZAVI LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para VIZZAVI LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Janine Butler como director el 09 feb 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Michael Yorston como director el 09 feb 2022

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Jonathan Paul Mitchell como director el 09 feb 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew Thurston Raggett como director el 09 feb 2022

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Sugnet Pretorius como director el 09 feb 2022

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2021

    5 páginasAA

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2020

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Janine Butler como director el 23 feb 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Nigel Evans como director el 23 feb 2021

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2019

    5 páginasAA

    Nombramiento de Mr Andrew Michael Yorston como director el 02 abr 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Diane Josephine Mcintyre como director el 16 mar 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2018

    5 páginasAA

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 14 feb 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de VIZZAVI LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro02357692
    75473330004
    MITCHELL, Jonathan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector243284220002
    PRETORIUS, Sugnet
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomSouth AfricanChartered Accountant284625720001
    RAGGETT, Andrew Thurston
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector200324290001
    HEATHER, Christopher Adrian
    Flat 5 2 Gainsford Street
    SE1 2NE London
    Secretario
    Flat 5 2 Gainsford Street
    SE1 2NE London
    BritishSolicitor73697810001
    HOWIE, Philip Robert Sutherland
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Secretario
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    British77939460004
    SCOTT, Stephen Roy
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    Secretario
    Bracken House
    Bunces Shaw Farley Hill
    RG7 1UU Reading
    Berkshire
    British25660590003
    BOULBEN, Frank Joseph Maxime
    9 Rue Du Temple
    FOREIGN Paris
    75004
    France
    Director
    9 Rue Du Temple
    FOREIGN Paris
    75004
    France
    FrenchDirector73697950001
    BRONFMAN JNR, Edgar
    375 Park Avenue
    New York
    Usa
    Director
    375 Park Avenue
    New York
    Usa
    AmericanCeo48429280001
    BUTLER, Janine
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector277534960001
    EVANS, David Nigel
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector134975040001
    EVANS, Mark
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishChief Financial Officer127017870001
    FINCH, Joanne Sarah
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishSenior Finance Manager158146620001
    GEITNER, Thomas
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    GermanDirector78550520002
    GENT, Christopher Charles, Sir
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    Director
    Bockhampton Manor
    RG17 7LS Lambourn
    Berkshire
    BritishCompany Director50867930003
    GERMOND, Philippe
    2 Ter Rue D'Alsace Lorraine
    Boulogne
    92100
    France
    Director
    2 Ter Rue D'Alsace Lorraine
    Boulogne
    92100
    France
    FrenchDirector67763260001
    HARPER, Alan Paul
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    BritishGroup Commercial Director27272400002
    HORN-SMITH, Julian Michael, Sir
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Director
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United KingdomBritishCompany Director102383880001
    ISAKSSON, Rolf Thomas
    56 Merrill Circle North
    Moraga
    Ca 94556
    Usa
    Director
    56 Merrill Circle North
    Moraga
    Ca 94556
    Usa
    SwedishDirector73922310001
    JOUSSEN, Friedrich Peter Johannes
    Lotharstrasse 117
    Duisberg
    47057
    Germany
    Director
    Lotharstrasse 117
    Duisberg
    47057
    Germany
    GermanyGermanDirector176065050001
    LAURENCE, Jonathan Guy
    SL9
    Director
    SL9
    United KingdomBritishCompany Director75160240003
    LEE, Simon Christopher
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    Director
    Moorlands
    Harrow Road West
    RH4 3BH Dorking
    Surrey
    United KingdomBritishDirector86697870001
    LESCURE, Pierre
    8 Avenue Raphael
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    Director
    8 Avenue Raphael
    FOREIGN Paris
    75016
    France
    FrenchDirector75863270002
    MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director173703620001
    MESSIER, Jean-Marie
    64 Boulevard De Courcelles
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    Director
    64 Boulevard De Courcelles
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    FrenchChairman67570640003
    NEWMARK, Evan Michael
    67 Abingdon Villas
    W8 6XB London
    Director
    67 Abingdon Villas
    W8 6XB London
    UsaCeo73697900001
    NOWAK, Thomas, Dr
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomGermanDirector174443800001
    PURKESS, Martin John
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector139360020001
    READ, Nicholas Jonathan
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director87149560001
    RICHARDS, Clarke Stewart
    Applegarth Moor Lane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    Director
    Applegarth Moor Lane
    South Newington
    OX15 4JQ Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector56522910002
    SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance Technology & Support158146600001
    YORSTON, Andrew Michael
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    Director
    Vodafone House
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector257275320001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de VIZZAVI LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Connection
    RG14 2FN Newbury
    Vodafone House
    Berkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalUnited Kingdom (England)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro2797438
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene VIZZAVI LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Rent deposit deed
    Creado el 09 oct 2001
    Entregado el 15 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of three million seven hundred and twenty nine thousand four hundred and twenty seven pounds sterling (3,729,427) together with all interest accured on the sum in the account referred to in the deed.
    Personas con derecho
    • Ivybridge Gp 1 Limited and Ivybridge Gp Limited Both as General Partners Under and for and on Behalf of the Ivybridge Investments Limited Partnership
    Transacciones
    • 15 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creado el 09 oct 2001
    Entregado el 15 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    The sum of three million seven hundred and twenty one thousand seven hundred and fifty five pounds sterling (£3,721,755) together with all interest accrued on the sum in the account referred to in the deed.
    Personas con derecho
    • Ivybridge Gp 1 Limited and Ivybridge Gp Limited Both as General Partners Under and for and on Behalf of the Ivybridge Investments Limited Partnership
    Transacciones
    • 15 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 25 sept 2000
    Entregado el 29 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from vizzavi limited (the principal debtor) to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued thereon
    Breve descripción
    Fixed charge over all deposit(s) in charged account re;-vizzavi limited a/c 200000 B47380300. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 29 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 07 nov 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed relating to rental deposit
    Creado el 31 ago 2000
    Entregado el 05 sept 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the underlease dated 22ND march 2000 defined therein relating to 19TH floor of the tower block forming part of the building shortly k/a the marble arch tower london W1
    Breve descripción
    The capital monies and all accrued interest thereon standing to the credit of the designated deposit account in which the deposit of £134,685 with barclays bank PLC 155 bishopsgate london.
    Personas con derecho
    • Marble Arch Tower Limited
    Transacciones
    • 05 sept 2000Registro de un cargo (395)
    • 05 mar 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0