QUADRIGA HOLDINGS LIMITED

QUADRIGA HOLDINGS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaQUADRIGA HOLDINGS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04019893
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    16 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    16 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    19 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    3 páginasAM19

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    3 páginasAM06

    Declaración de la propuesta del administrador

    3 páginasAM03

    Nombramiento de un administrador

    3 páginasAM01

    Domicilio social registrado cambiado de Forum 1 Station Road Theale Berkshire RG7 4RA a Devonshire House 60 Goswell Road London EC1M 7AD el 07 mar 2019

    2 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Notification de Seale Alonzo Moorer en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 jul 2016

    2 páginasPSC01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    18 páginasAA

    Cese del nombramiento de Christopher John Maityard como director el 26 jun 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 19 jun 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de James Gerard Naro como director el 07 mar 2017

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    21 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 jun 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital22 jul 2016

    Estado de capital el 22 jul 2016

    • Capital: GBP 75,724,023
    SH01

    Nombramiento de Mr Christopher John Maityard como director el 13 may 2016

    2 páginasAP01

    Registro de la carga 040198930008, creada el 18 dic 2015

    112 páginasMR01

    Memorándum y Estatutos

    16 páginasMA

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2015

    35 páginasAA

    Cese del nombramiento de Isabelle Sarah Kirk como secretario el 21 ago 2015

    1 páginasTM02

    Registro de la carga 040198930007, creada el 07 ago 2015

    55 páginasMR01

    Exercice comptable en cours raccourci du 31 mar 2016 au 31 dic 2015

    1 páginasAA01

    Nombramiento de Mr James Gerard Naro como director el 09 jul 2015

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MOORER, Seale Alonzo
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Director
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican199604390001
    AULT, Isabel Mary Katherine
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secretario
    87 Shaftesbury Road
    SP2 0DU Wilton
    Jasmine Cottage
    Wiltshire
    United Kingdom
    128525910001
    DALLISON, Adrian John
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    Secretario
    41 Common Hill
    BA14 6EE Steeple Ashton
    Wiltshire
    British52541710002
    JENKINS, Elisabeth Anne
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    Secretario
    50a Cyril Mansions
    Prince Of Wales Drive
    SW11 4HW London
    British72837960002
    KIRK, Isabelle Sarah
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    United Kingdom
    199579500001
    MOHINDRA, Ravi Kumar
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    Secretario
    12 Falcon House Gardens
    Woolton Hill
    RG20 9UQ Newbury
    Berkshire
    British122688990001
    MORDECAI, Laura Rose
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    Secretario
    Flat 15
    23 Chartfield Avenue
    SW15 6DX Putney
    London
    British65797190002
    WATSON, David Andrew
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    Secretario
    58 Shepherds Lane
    Caversham Heights
    RG4 7JL Reading
    British52990930003
    DAVID VENUS & COMPANY LLP
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Hersham Road
    KT12 1RZ Walton-On-Thames
    42-50
    Surrey
    United Kingdom
    131429630001
    TJG SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Secretario designado corporativo
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    900018860001
    ANDRADI, Benedict Pius Marilaan
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    Director
    16 Knole Way
    TN13 3RS Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish82360580001
    AUSTIN, Terry Alan
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    Director
    The Barn
    Handpost Farm Barkham
    RG41 4TN Wokingham
    Berkshire
    British82652640001
    BARDEN-STYLIANOU, Stelios Stephen
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    Director
    47 Carlyle Court
    Chelsea Harbour
    SW10 0UQ London
    EnglandBritish125782940001
    BUDIE, Marcus Johanes Theodorus
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomDutch105980560001
    CRABB, Ian Denis
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish70017710003
    DUNCAN, Fraser Scott
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    Director
    25 Kippington Road
    TN13 2LJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish57508670001
    FORBES, Alistair Robert Ballantyne
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    Director
    Spring House
    Browns Lane Great Bedwyn
    SN8 3LR Marlborough
    Wiltshire
    United KingdomBritish168893980001
    GALLAGHER, Patrick James
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    Director
    Fulling Mill
    The Weir
    RG28 7RA Whitchurch
    Hampshire
    British77355310002
    HANDS, Guy
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    Director
    90 Kippington Road
    TN13 2LL Sevenoaks
    Kent
    British2519120002
    HOWES, Lewis Verlie
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    Director
    Gisburn
    50 Woodham Waye
    GU21 5SJ Woking
    Surrey
    EnglandBritish62776210004
    HULL, Jonathan
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Portsmouth Road
    KT10 9AD Esher
    Thames House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish116761670001
    LEVY, Lionel Anthony
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    Director
    29 Pangbourne Drive
    Stanmore
    HA7 4RA Middlesex
    United KingdomBritish105270770001
    MAITYARD, Christopher John
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Director
    Station Rd
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    EnglandBritish210342460001
    MARSH, Gary Neil
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Director
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    EnglandBritish122518590001
    MILLER, Louise Ann
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    Director
    Pound Cottages
    High Street
    RG8 9JH Streatley
    6
    Berkshire
    United Kingdom
    British127375160002
    NARO, James Gerard
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    Director
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Forum 1
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican199606110001
    NWANA, Hyacinth Sama, Dr
    19 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    Director
    19 York Gardens
    KT12 3EP Walton On Thames
    Surrey
    British53962580002
    PATEL, Harnish Natubhai
    High Pines
    Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    Director
    High Pines
    Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    British90038150001
    SPRUZEN, David Andrew
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    Director
    Homewood
    The Avenue, Farnham Common
    SL2 3JY Slough
    Bucks
    EnglandBritish110080200001
    SUNDERLAND, Neil Vernon
    Zuercherstrasse 80a
    Uitikon
    8142 Switzerland
    Director
    Zuercherstrasse 80a
    Uitikon
    8142 Switzerland
    Swiss44808550001
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Director
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritish,American106792270001
    TATARYN, Myron Anton
    The Leys
    The Street
    NR35 2BJ Topcroft
    Suffolk
    Director
    The Leys
    The Street
    NR35 2BJ Topcroft
    Suffolk
    United KingdomBritish105980670001
    TAYLOR, Roger David
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Director
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    United KingdomBritish73602910003
    TYRRELL, Patricia Valentine
    Le Bas Marais
    Na Lliers
    La Vendee 85370
    France
    Director
    Le Bas Marais
    Na Lliers
    La Vendee 85370
    France
    British105980890001
    WAKE, Lorna
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    Director
    Forum 1
    Station Road
    RG7 4RA Theale
    Berkshire
    United KingdomBritish210114660001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de QUADRIGA HOLDINGS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Seale Alonzo Moorer
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    09 jul 2016
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Devonshire House
    No
    Nacionalidad: American
    País de residencia: United States
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Exceptional Innovation B.V.
    Hoogoorddreef 15
    1101 Ba Amsterdam
    Amerika Building
    Netherlands
    06 abr 2016
    Hoogoorddreef 15
    1101 Ba Amsterdam
    Amerika Building
    Netherlands
    No
    Forma jurídicaPrivate Company With Limited Liability
    País de registroNetherlands
    Autoridad legalDutch Company Law
    Lugar de registroNetherlands
    Número de registro855133697
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene QUADRIGA HOLDINGS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 18 dic 2015
    Entregado el 23 dic 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Trust Company America
    Transacciones
    • 23 dic 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 07 ago 2015
    Entregado el 18 ago 2015
    Pendiente
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Trust Company Americas
    Transacciones
    • 18 ago 2015Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 05 dic 2013
    Entregado el 06 dic 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Lloyds Bank PLC (Previously Known as Lloyds Tsb Bank PLC)
    Transacciones
    • 06 dic 2013Registro de una carga (MR01)
    • 16 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 11 feb 2010
    Entregado el 12 feb 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 12 feb 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 16 jul 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Fixed and floating security between, inter alia, the chargor and the security agent (as defined)(the "security document")
    Creado el 03 dic 2001
    Entregado el 19 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future moneys, debts and liabilities due, owing or incurred by the chargor to any finance party under or in connection with any finance document (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of Thefinance Parties (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 19 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Fixed and floating security document between the chargors (as defined) and the security agent
    Creado el 03 dic 2001
    Entregado el 19 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys,debts and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") to any finance party (as defined) under or in connection with any finance document (as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC,London,as Security Agent for the Finance Parties
    Transacciones
    • 19 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of pledge of registered shares between the pledgor the pledgee and the company (as defined) executed outside the united kingdom and comprising property situated there
    Creado el 14 mar 2001
    Entregado el 28 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Any and all of the present and future monetary obligations and liabilities of the pledgor to the pledgee (including the parallel debt) whether due and payable or not and whether contingent or not under or pursuant to the deed (the secured obligations)(as defined)
    Breve descripción
    As security for the secured obligations the pledgor agrees to grant and grants to the pledgee the right of the pledge and the pledgee accepts the right of the pledge. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC in Its Capacity as Security Agent (The "Pledgee")
    Transacciones
    • 28 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 03 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors to any finance party under the finance documents or any hedging creditor under the hedging documents
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all shares and all related rights accruing to the shares and all interest in the shares all moneys standing to the credit of any account all book and other debts the goodwill uncalled capital and by way of floating charge all assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC as Security Agent for and on Behalf of the Finance Parties (Asdefined) (the Security Agent)
    Transacciones
    • 03 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 01 dic 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)

    ¿Tiene QUADRIGA HOLDINGS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    15 feb 2019Inicio de la administración
    17 feb 2021Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Ian Robert
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Profesional
    Kingston Smith & Partners Llp
    Devonshire House
    EC1M 7AD 60 Goswell Road
    London
    Christopher Purkiss
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London
    Profesional
    Devonshire House
    60 Goswell Road
    EC1M 7AD London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0