PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04021804 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
- Administración de bienes inmobiliarios por cuenta ajena (68320) / Actividades inmobiliarias
¿Dónde se encuentra PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 4-6 Colebrooke Place N1 8HZ London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PARTNERS FOR IMPROVEMENT IN ISLINGTON LIMITED | 07 jun 2001 | 07 jun 2001 |
| PARTNERS FOR ISLINGTON LIMITED | 21 jun 2000 | 21 jun 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 05 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mrs Patricia Springett como director el 01 oct 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2024 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Vikki Louise Everett como director el 15 abr 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mrs Nicola Covington como director el 19 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Martin Timothy Smith como director el 19 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2023 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr. Mark Richard Batchelor como director el 25 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon William Vevers como director el 25 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2022 | 29 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr. Frank David Laing como director el 23 mar 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||
Cese del nombramiento de Karen Marie Hill como director el 02 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 28 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Neal John Ackcral como director el 24 sept 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 30 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 30 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Mrs Charlotte Sophie Ellen Douglass el 22 jul 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de David Keith Gannicott como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
| 97584300011 | ||||||||||
| ACKCRAL, Neal John | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London Hyde Housing United Kingdom | United Kingdom | British | 103881880001 | |||||||||
| BATCHELOR, Mark Richard | Director | SE1 9EQ London 30 Park Street United Kingdom | United Kingdom | British | 309610640001 | |||||||||
| COVINGTON, Nicola | Director | 280 Bishopsgate EC2M 4AG London Abrdn Plc England | United Kingdom | British | 207391580001 | |||||||||
| DOUGLASS, Charlotte Sophie Ellen | Director | Welken House 10-11 Charterhouse Square EC1M 6EH London Eqitex Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | 245967540001 | |||||||||
| LAING, Frank David | Director | EH2 2LL Edinburgh 1 George Street , United Kingdom United Kingdom | Scotland | British | 256185820002 | |||||||||
| SPRINGETT, Patricia | Director | 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London Equitex, 3rd Floor, South Building United Kingdom | United Kingdom | Spanish | 316974590001 | |||||||||
| CROSS, Stephen | Secretario | 2 Breach Cottages Breach Lane Upchurch ME9 7PE Sittingbourne Kent | British | 3480870003 | ||||||||||
| CROSS, Stephen | Secretario | Winterbourne Wrens Road Borden ME9 8JD Sittingbourne Kent | British | 3480870002 | ||||||||||
| HARWOOD, Keith Anthony Reginald | Secretario | 32 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | British | 29167420004 | ||||||||||
| HAYNES, Victoria | Secretario | Basted Lane Crouch, Borough Green TN15 8PY Sevenoaks Dove Cottage Kent England | British | 182412280001 | ||||||||||
| RYAN, John Benedict | Secretario | 1 Leather Lane Gomshall GU5 9NB Guildford Surrey | British | 70736030001 | ||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| ADAMS, Jeffrey William | Director | Little Scords Scords Lane, Toys Hill TN16 1QE Westerham Kent | United Kingdom | British | 3480850001 | |||||||||
| ALLISON, Tracy Helen | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London The Hyde Group United Kingdom | United Kingdom | British | 181406590001 | |||||||||
| ASHBROOK, Philip Peter | Director | 88 Cowslip Hill SG6 4EX Letchworth Hertfordshire | British | 72272070002 | ||||||||||
| CHARLESWORTH, Andrew Gilbert | Director | c/o John Laing 150 Victoria Street SW1E 5LB London Allington House United Kingdom | United Kingdom | British | 155424980001 | |||||||||
| CHATFIELD, Simon Craig | Director | Yorke Road RH2 9HH Reigate 21 Surrey England | England | British | 76670050002 | |||||||||
| CHRISTOPHER, Raymond Gary | Director | Hayward Road KT7 0BF Thames Ditton 3 Surrey | England | British | 135981290001 | |||||||||
| CROSS, Stephen | Director | 2 Breach Cottages Breach Lane Upchurch ME9 7PE Sittingbourne Kent | United Kingdom | British | 3480870003 | |||||||||
| DUGGAN, Kevin Barry | Director | 1 Ash Tree Court Ash Tree Drive TN15 6LT West Kingsdown Kent | England | British | 5330260003 | |||||||||
| EVERETT, Vikki Louise | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 97009800001 | |||||||||
| GANNICOTT, David Keith | Director | SE1 9EQ London 30 Park Street United Kingdom | England | British | 118321250001 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Director | 1 Bread Street EC4M 9HH London Bow Bells House United Kingdom | England | British | 104265470002 | |||||||||
| HILL, Karen Marie | Director | Durham Road East Finchley N2 9DR London 113 United Kingdom | England | British | 104265470002 | |||||||||
| JENKINSON, Jane Elizabeth | Director | Bathurst Mews W2 2SB London 16 England | England | British | 147588390001 | |||||||||
| JOHNSTON, Nicola | Director | Carholme Road SE23 2HT London First Floor Flat, 35 United Kingdom | British | 134124490001 | ||||||||||
| MCLINTOCK, Matthew Joseph | Director | WC2B 6AN London 1 Kingsway United Kingdom | England | British | 230346020001 | |||||||||
| MICKLEBURGH, Andrew Simon | Director | The Granary, Dunsdale Brasted Road TN16 1LJ Westerham Kent | England | British | 61711010004 | |||||||||
| PRITCHARD, Jamie | Director | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 172824610001 | |||||||||
| SEEFF, Geoffrey Michael, Dr | Director | 32c Churchfields South Woodford L18 2QZ London | United Kingdom | British | 20836810001 | |||||||||
| SMITH, Martin Timothy | Director | EC4M 9HH Edinburgh 6 St. Andrew Square United Kingdom | Scotland | British | 82478070008 | |||||||||
| STEPHENS, Karen Elisabeth | Director | Navarino Road BN11 2NE Worthing 45 West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | 138309330001 | |||||||||
| TIBBITTS, John Alfred Neville | Director | 30 Park Street SE1 9EQ London The Hyde Group United Kingdom | England | British | 71709970001 | |||||||||
| TITHERINGTON, Thomas Gore | Director | 161 Algernon Road Lewisham SE13 7AP London | British | 87898840001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PFI ISLINGTON (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Infrastructure (No. 3) Limited | 31 ago 2016 | Canary Wharf E14 5HJ London 20 Churchill Place | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Palio (No. 8) Limited | 31 ago 2016 | WC2B 6AN London 1 Kingsway | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0