PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04023094
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    GATORADE LIMITED19 oct 200619 oct 2006
    WALKERS INTERMEDIATE HOLDING COMPANY LIMITED26 sept 200226 sept 2002
    GOLDEN WONDER FINANCE LIMITED27 jul 200027 jul 2000
    DE FACTO 857 LIMITED28 jun 200028 jun 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta29 dic 2012

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 17 sept 2014

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06
    capital

    Resoluciones

    Cancellation of share prem acct 15/09/2014
    RES13

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 ago 2014

    • Capital: GBP 93,757,033
    4 páginasSH01

    Consolidación de acciones el 20 ago 2014

    5 páginasSH02

    Resoluciones

    Resolutions
    21 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01
    capital

    Resoluciones

    Consolidated shares 20/08/2014
    RES13

    Nombramiento de Claire Ellen Stone como director el 17 abr 2014

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John L Sigalos como director el 17 abr 2014

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 11 mar 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario el 04 nov 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Anwar Yaseen Ahmed como secretario el 04 nov 2013

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2012

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Anwar Yaseen Ahmed como secretario el 07 mar 2013

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario el 07 mar 2013

    1 páginasTM02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada

    1 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr John L Sigalos como director el 07 sept 2012

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    13 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 26 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cambio de datos del director Victoria Elizabeth Evans el 27 abr 2012

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    182647960001
    AVERISS, Joanne Kerry
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish57057370001
    EVANS, Victoria Elizabeth
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish103389550003
    STONE, Claire Ellen
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    EnglandBritish111950160001
    AHMED, Anwar Yaseen
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    176432560001
    AHMED, Anwar Yaseen
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    Secretario
    2 St Johns Road
    Tackley
    OX5 3AP Kidlington
    Oxfordshire
    British96045380002
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Secretario
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    British142394800001
    DEAN, Sharon Julie
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Secretario
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    148279850002
    WILLIAMS, Mark
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    Secretario
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    British76155240003
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secretario designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    AMIN, Salman
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    Director
    25 Marlborough Place
    St John's Wood
    NW8 0PG London
    Usa116417620001
    BOYD, Stephen Alexander
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    Director
    Church Lane
    LE15 8EY Edith Weston
    12
    Rutland
    EnglandBritish142394800001
    FRASER, Stanley Walter
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    Director
    48 Grovewood Close
    WD3 5PX Chorleywood
    Hertfordshire
    British68204280001
    GLENN, Martin Richard
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    Director
    Manor House
    Stanford Dingley
    RG7 6LS Reading
    Berkshire
    UkBritish61897350002
    HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Director
    1 High Close
    The Drive
    WD3 4DZ Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish77901460001
    KARLSSON, Tommy Harry Vilhelm
    15 Rue Lebouteux
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    Director
    15 Rue Lebouteux
    FOREIGN Paris
    75017
    France
    SwedenSwedish116317060002
    SHARPE, Clive Richard
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    Director
    Knighton Rise
    LE2 2RE Leicester
    18
    Leics
    EnglandBritish134995270001
    SIGALOS, John L
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    Director
    1600 Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SA Reading
    Berkshire
    United KingdomAmerican170690380001
    SIMPSON DENT, Jonathan
    78 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QP London
    Director
    78 Hotham Road
    Putney
    SW15 1QP London
    British110396210001
    VAN DER EEMS, Jeffrey Peter
    72 Stanley Road
    East Sheen
    SW14 7DZ London
    Director
    72 Stanley Road
    East Sheen
    SW14 7DZ London
    EnglandBritish118890890001
    WILLIAMS, Mark
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    Director
    6 Setter Combe
    RG42 2FD Warfield
    Berkshire
    British76155240003
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Director designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Director designado corporativo
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    ¿Tiene PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company
    Creado el 11 ago 2000
    Entregado el 16 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 16 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 jul 2000
    Entregado el 02 ago 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever.
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lehman Commercial Paper Inc. (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 02 ago 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 sept 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0