PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04023094 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Fabricación de otros productos alimenticios, n.c.o.p. (10890) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GATORADE LIMITED | 19 oct 2006 | 19 oct 2006 |
| WALKERS INTERMEDIATE HOLDING COMPANY LIMITED | 26 sept 2002 | 26 sept 2002 |
| GOLDEN WONDER FINANCE LIMITED | 27 jul 2000 | 27 jul 2000 |
| DE FACTO 857 LIMITED | 28 jun 2000 | 28 jun 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 29 dic 2012 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 17 sept 2014
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 20 ago 2014
| 4 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Consolidación de acciones el 20 ago 2014 | 5 páginas | SH02 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 21 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Claire Ellen Stone como director el 17 abr 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de John L Sigalos como director el 17 abr 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 mar 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario el 04 nov 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Anwar Yaseen Ahmed como secretario el 04 nov 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2012 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 jul 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Anwar Yaseen Ahmed como secretario el 07 mar 2013 | 1 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Sharon Julie Dean como secretario el 07 mar 2013 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada | 1 páginas | AD03 | ||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr John L Sigalos como director el 07 sept 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011 | 13 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 26 jul 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Victoria Elizabeth Evans el 27 abr 2012 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAN, Sharon Julie | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 182647960001 | |||||||
| AVERISS, Joanne Kerry | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | 57057370001 | |||||
| EVANS, Victoria Elizabeth | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | 103389550003 | |||||
| STONE, Claire Ellen | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | England | British | 111950160001 | |||||
| AHMED, Anwar Yaseen | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 176432560001 | |||||||
| AHMED, Anwar Yaseen | Secretario | 2 St Johns Road Tackley OX5 3AP Kidlington Oxfordshire | British | 96045380002 | ||||||
| BOYD, Stephen Alexander | Secretario | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | British | 142394800001 | ||||||
| DEAN, Sharon Julie | Secretario | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | 148279850002 | |||||||
| WILLIAMS, Mark | Secretario | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | 76155240003 | ||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 | |||||||
| AMIN, Salman | Director | 25 Marlborough Place St John's Wood NW8 0PG London | Usa | 116417620001 | ||||||
| BOYD, Stephen Alexander | Director | Church Lane LE15 8EY Edith Weston 12 Rutland | England | British | 142394800001 | |||||
| FRASER, Stanley Walter | Director | 48 Grovewood Close WD3 5PX Chorleywood Hertfordshire | British | 68204280001 | ||||||
| GLENN, Martin Richard | Director | Manor House Stanford Dingley RG7 6LS Reading Berkshire | Uk | British | 61897350002 | |||||
| HAMPTON, Anthony Nicholas Seymour | Director | 1 High Close The Drive WD3 4DZ Rickmansworth Hertfordshire | England | British | 77901460001 | |||||
| KARLSSON, Tommy Harry Vilhelm | Director | 15 Rue Lebouteux FOREIGN Paris 75017 France | Sweden | Swedish | 116317060002 | |||||
| SHARPE, Clive Richard | Director | Knighton Rise LE2 2RE Leicester 18 Leics | England | British | 134995270001 | |||||
| SIGALOS, John L | Director | 1600 Arlington Business Park Theale RG7 4SA Reading Berkshire | United Kingdom | American | 170690380001 | |||||
| SIMPSON DENT, Jonathan | Director | 78 Hotham Road Putney SW15 1QP London | British | 110396210001 | ||||||
| VAN DER EEMS, Jeffrey Peter | Director | 72 Stanley Road East Sheen SW14 7DZ London | England | British | 118890890001 | |||||
| WILLIAMS, Mark | Director | 6 Setter Combe RG42 2FD Warfield Berkshire | British | 76155240003 | ||||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Director designado corporativo | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006090001 | |||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Director designado corporativo | 10 Snow Hill EC1A 2AL London | 900006100001 |
¿Tiene PEPSICO PROPERTY MANAGEMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture dated 29 july 2000 as amended and restated on 11 august 2000 by a composite restatement agreement dated 10 august 2000 (the "debenture") issued by the company | Creado el 11 ago 2000 Entregado el 16 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada In favour of the chargee all money or liabilities due owing or incurred to any secured party by the charging company or any other charging company under the debenture or any other obligor under any finance document in whatsoever manner | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 29 jul 2000 Entregado el 02 ago 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein and each of the other obligors under the debenture and under any finance document to the chargee on any account whatsoever. | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0