ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04028670 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
- Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros
¿Dónde se encuentra ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Embankment West Tower 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CQ COMMERCIAL LIMITED | 28 jul 2000 | 28 jul 2000 |
| CROFTBLACK ASSOCIATES LIMITED | 07 jul 2000 | 07 jul 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Ian James Donaldson como director el 31 dic 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Stewart Kennedy como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Janice Deakin como director el 30 dic 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Annabel Felicity Wilson como secretario el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de David Robert Harding como director el 31 dic 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Ms Janice Deakin como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP03 | ||
Nombramiento de Mr Craig David Ball como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Scott Stewart Kennedy como director el 31 dic 2018 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Gilles Normand como director el 03 oct 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2018 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Rockford Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jun 2017 | 2 páginas | PSC05 | ||
Cambio de datos del director Mr Gilles Normand el 19 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director David Robert Harding el 19 jun 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLARKE, Dean | Secretario | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | 255364210001 | |||||||
| BALL, Craig David | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 109298830003 | |||||
| DONALDSON, Ian James | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 253784440001 | |||||
| DESRAY, Georges | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169861040001 | |||||||
| HARDILL, Allan | Secretario | The Old Dairy Hey Farm Holt Head Road HD7 5TU Slaithwaite Yorkshire | British | 70902270002 | ||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Secretario | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | English | 1778900007 | ||||||
| MOULDING, Paul | Secretario | 17 Lindale Road Longridge PR3 3FT Preston Lancashire | British | 15736360001 | ||||||
| PLUMER, Christian Charles | Secretario | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189565350001 | |||||||
| WILLS, Michael John | Secretario | 22 Fleetwood Road Carleton FY6 7NL Poulton Le Fylde Lancashire | British | 58800280001 | ||||||
| WILSON, Annabel Felicity | Secretario | RG1 8DA Reading Norman Place United Kingdom | 196039110001 | |||||||
| TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| BROWNE, Mark Christopher Clinton | Director | 50 Greave Road Hade Edge HD9 2AQ Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | 102521800001 | |||||
| CATTERALL, Philip Richard | Director | 53j Randolph Avenue W9 1BQ London | United Kingdom | British | 72395570001 | |||||
| CLARE, Anthony Peter | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| DALY, James Francis | Director | 27 High Street South Milford LS25 5AA Leeds West Yorkshire | British | 102521790001 | ||||||
| DAVIDSON, Leon Laurence | Director | 10 Saint Andrews Walk LS17 7TS Leeds Yorkshire | England | Irish | 80631150001 | |||||
| DEAKIN, Janice | Director | Eclipse Park Sittingbourne Road ME14 3EN Maidstone Towergate House United Kingdom | England | British | 238355920001 | |||||
| DESRAY, Georges | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| HALPIN, Peter Joseph | Director | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | United Kingdom | British | 38789050002 | |||||
| HARDILL, Allan | Director | The Old Dairy Hey Farm Holt Head Road HD7 5TU Slaithwaite Yorkshire | England | British | 70902270002 | |||||
| HARDING, David Robert | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 196407900002 | |||||
| KENNEDY, Scott Stewart | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | England | British | 211745270001 | |||||
| NORMAND, Gilles | Director | 101 Cathedral Approach M3 7FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | United Kingdom | French | 175288680002 | |||||
| PLUMER, Christian Charles | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 130813500001 | |||||
| TURNER, Allister Paul | Director | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | British | 86414540001 | |||||
| WEATHERS, Gail Elizabeth | Director | 9 Low Fold LS19 6DE Rawden West Yorkshire | England | British | 102735780001 | |||||
| WILLS, Michael John | Director | 22 Fleetwood Road Carleton FY6 7NL Poulton Le Fylde Lancashire | British | 58800280001 | ||||||
| COMPANY DIRECTORS LIMITED | Director designado corporativo | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockford Group Limited | 06 abr 2016 | 101 Cathedral Approach M3 4FB Salford Embankment West Tower United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture containing fixed and floating charges | Creado el 22 abr 2003 Entregado el 23 abr 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 14 mar 2002 Entregado el 19 mar 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage debenture | Creado el 14 may 2001 Entregado el 01 jun 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0