ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED

ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04028670
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    • Seguros no de vida (65120) / Actividades financieras y de seguros

    ¿Dónde se encuentra ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Embankment West Tower
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CQ COMMERCIAL LIMITED28 jul 200028 jul 2000
    CROFTBLACK ASSOCIATES LIMITED07 jul 200007 jul 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2019

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Ian James Donaldson como director el 31 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Scott Stewart Kennedy como director el 30 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Janice Deakin como director el 30 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Annabel Felicity Wilson como secretario el 31 dic 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David Robert Harding como director el 31 dic 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Janice Deakin como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Dean Clarke como secretario el 31 dic 2018

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr Craig David Ball como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Scott Stewart Kennedy como director el 31 dic 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Gilles Normand como director el 03 oct 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 23 jul 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 21 jul 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Modification des détails de Rockford Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 jun 2017

    2 páginasPSC05

    Cambio de datos del director Mr Gilles Normand el 19 jun 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director David Robert Harding el 19 jun 2017

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLARKE, Dean
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Secretario
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    255364210001
    BALL, Craig David
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish109298830003
    DONALDSON, Ian James
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish253784440001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    169861040001
    HARDILL, Allan
    The Old Dairy Hey Farm
    Holt Head Road
    HD7 5TU Slaithwaite
    Yorkshire
    Secretario
    The Old Dairy Hey Farm
    Holt Head Road
    HD7 5TU Slaithwaite
    Yorkshire
    British70902270002
    HARGREAVES, Sally Anne
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Secretario
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    English1778900007
    MOULDING, Paul
    17 Lindale Road
    Longridge
    PR3 3FT Preston
    Lancashire
    Secretario
    17 Lindale Road
    Longridge
    PR3 3FT Preston
    Lancashire
    British15736360001
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Secretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    189565350001
    WILLS, Michael John
    22 Fleetwood Road
    Carleton
    FY6 7NL Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Secretario
    22 Fleetwood Road
    Carleton
    FY6 7NL Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British58800280001
    WILSON, Annabel Felicity
    RG1 8DA Reading
    Norman Place
    United Kingdom
    Secretario
    RG1 8DA Reading
    Norman Place
    United Kingdom
    196039110001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secretario designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    BARDET, Christophe Marie Fred
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrench165770320001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish132720300001
    BROWNE, Mark Christopher Clinton
    50 Greave Road
    Hade Edge
    HD9 2AQ Holmfirth
    West Yorkshire
    Director
    50 Greave Road
    Hade Edge
    HD9 2AQ Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritish102521800001
    CATTERALL, Philip Richard
    53j Randolph Avenue
    W9 1BQ London
    Director
    53j Randolph Avenue
    W9 1BQ London
    United KingdomBritish72395570001
    CLARE, Anthony Peter
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Director
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    United KingdomBritish51441260002
    DALY, James Francis
    27 High Street
    South Milford
    LS25 5AA Leeds
    West Yorkshire
    Director
    27 High Street
    South Milford
    LS25 5AA Leeds
    West Yorkshire
    British102521790001
    DAVIDSON, Leon Laurence
    10 Saint Andrews Walk
    LS17 7TS Leeds
    Yorkshire
    Director
    10 Saint Andrews Walk
    LS17 7TS Leeds
    Yorkshire
    EnglandIrish80631150001
    DEAKIN, Janice
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    United Kingdom
    Director
    Eclipse Park
    Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Towergate House
    United Kingdom
    EnglandBritish238355920001
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandFrench167333040002
    HALPIN, Peter Joseph
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Director
    Swinton House
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    United KingdomBritish38789050002
    HARDILL, Allan
    The Old Dairy Hey Farm
    Holt Head Road
    HD7 5TU Slaithwaite
    Yorkshire
    Director
    The Old Dairy Hey Farm
    Holt Head Road
    HD7 5TU Slaithwaite
    Yorkshire
    EnglandBritish70902270002
    HARDING, David Robert
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United KingdomBritish196407900002
    KENNEDY, Scott Stewart
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    EnglandBritish211745270001
    NORMAND, Gilles
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    Director
    101 Cathedral Approach
    M3 7FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    United KingdomFrench175288680002
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish130813500001
    TURNER, Allister Paul
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Director
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandBritish86414540001
    WEATHERS, Gail Elizabeth
    9 Low Fold
    LS19 6DE Rawden
    West Yorkshire
    Director
    9 Low Fold
    LS19 6DE Rawden
    West Yorkshire
    EnglandBritish102735780001
    WILLS, Michael John
    22 Fleetwood Road
    Carleton
    FY6 7NL Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Director
    22 Fleetwood Road
    Carleton
    FY6 7NL Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British58800280001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Director designado corporativo
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Rockford Group Limited
    101 Cathedral Approach
    M3 4FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    06 abr 2016
    101 Cathedral Approach
    M3 4FB Salford
    Embankment West Tower
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company, Limited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroEngland And Wales
    Número de registro4380883
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene ROCKFORD INSURANCE BROKERS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 22 abr 2003
    Entregado el 23 abr 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 abr 2003Registro de un cargo (395)
    • 01 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 14 mar 2002
    Entregado el 19 mar 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 19 mar 2002Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 may 2001
    Entregado el 01 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 01 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 13 jul 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0