ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04033332
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    • Otras actividades de asistencia sanitaria (86900) / Actividades sanitarias y de asistencia social

    ¿Dónde se encuentra ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BROADOAKS VCT LIMITED28 sept 200028 sept 2000
    HILLGATE (181) LIMITED13 jul 200013 jul 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario el 09 oct 2012

    1 páginasTM02

    Notificación de finalización del acuerdo voluntario

    6 páginas1.4

    Cese del nombramiento de Timothy James Bolot como director el 17 ago 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital17 jul 2012

    Estado de capital el 17 jul 2012

    • Capital: GBP 11,190
    SH01

    Notificación al Registro Mercantil del acuerdo voluntario de empresas que entra en vigor

    4 páginas1.1

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 15 nov 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Andrew Smith como director el 01 nov 2011

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Stephen Jonathan Taylor como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Timothy James Bolot como director el 26 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2010

    27 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01

    legacy

    7 páginasMG01

    Cese del nombramiento de William Mcleish como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Richard Midmer como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Cuentas completas preparadas hasta el 27 sept 2009

    24 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr David Andrew Smith el 07 ene 2010

    2 páginasCH01

    Nombramiento de un director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Smith como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Andrew Smith como director

    2 páginasAP01

    ¿Quiénes son los directivos de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GAIN, Jonathan Mark
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    Secretario
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    British47508930005
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304380001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Secretario
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    British174231320001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secretario designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Director
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Director
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Director
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FRYER, Martin
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    Director
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    British72517560003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Director
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Director
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Director
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    ROBINSON, Anthony Leake
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British48323880002
    ROGERS, Michael Greig
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    Director
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish107156650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Director
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Director
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Director
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Director
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Director
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Director designado corporativo
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    ¿Tiene ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Supplemental legal mortgage
    Creado el 06 may 2011
    Entregado el 20 may 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Broad oaks gaul road march t/no CB295973 see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 20 may 2011Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 29 feb 2008
    Entregado el 14 mar 2008
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transacciones
    • 14 mar 2008Registro de un cargo (395)
    Debenture
    Creado el 06 jun 2007
    Entregado el 19 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 19 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 jul 2006
    Entregado el 20 jul 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 20 jul 2006Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 abr 2005
    Entregado el 15 abr 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 15 abr 2005Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 17 sept 2004
    Entregado el 28 sept 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transacciones
    • 28 sept 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 30 abr 2004
    Entregado el 11 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transacciones
    • 11 may 2004Registro de un cargo (395)
    • 08 ago 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 29 sept 2000
    Entregado el 19 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock deed whereby the company issued to the lender 14% secured stock loan
    Breve descripción
    Land at gaul road march cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transacciones
    • 19 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 11 ago 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    20 jun 2012Fecha de la reunión para aprobar el CVA
    20 ago 2012Fecha de finalización o terminación del CVA
    Acuerdo voluntario de reestructuración empresarial (CVA)
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Profesional
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    Profesional
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0