B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaB MIDGLEY SEAFOODS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04036033
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    • Procesamiento y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (10200) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    6 páginasLIQ13

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 09 jul 2021

    6 páginasLIQ03

    Renuncia de un liquidador

    3 páginasLIQ06

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    42 páginas600

    Domicilio social registrado cambiado de C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH a 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE el 07 may 2021

    2 páginasAD01

    Domicilio social registrado cambiado de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW a 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH el 05 ago 2020

    2 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    5 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    3 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 jul 2020

    LRESSP

    Cessation de English Seafoods Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mar 2020

    1 páginasPSC07

    Notification de Youngs Seafood Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mar 2020

    2 páginasPSC02

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 30 mar 2020

    • Capital: GBP 200
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13

    Cese del nombramiento de Jenny Nancy Loncaster como director el 25 sept 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Timothy Mark Busby como director el 12 sept 2019

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours prolongé du 30 sept 2019 au 31 mar 2020

    1 páginasAA01

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado de PO Box 16 Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE England a Karro Food Group Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 páginasAD02

    Nombramiento de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont como director el 04 jul 2019

    2 páginasAP01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 sept 2018

    4 páginasAA

    Cese del nombramiento de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited como secretario el 04 jul 2019

    1 páginasTM02

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    ¿Quiénes son los directivos de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Director
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Secretario
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    MIDGLEY, Lisbeth Jane
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Secretario
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    British70971410001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secretario corporativo
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro02249348
    75197930001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secretario designado corporativo
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRITTON, Christopher Paul
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Director
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandDutch166335910001
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Director
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Director
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Director
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205633180001
    MIDGLEY, Barry George
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Director
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish38013830001
    MIDGLEY, Fraser
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    Director
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    British70971400002
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Director
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Director
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    29 mar 2020
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    No
    Forma jurídicaYoungs Seafood Ltd
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro3751665
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Forma jurídicaLimited Company
    País de registroEngland
    Autoridad legalEngland & Wales
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro02353338
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 23 oct 2008
    Entregado el 01 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transacciones
    • 01 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 23 sept 2008
    Entregado el 04 oct 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transacciones
    • 04 oct 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 21 mar 2007
    Entregado el 31 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale the Security Agent
    Transacciones
    • 31 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 16 mar 2006
    Entregado el 25 mar 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transacciones
    • 25 mar 2006Registro de un cargo (395)
    • 23 oct 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2005
    Entregado el 17 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All material premises being l/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transacciones
    • 17 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 26 abr 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Security accession deed
    Creado el 30 jun 2004
    Entregado el 10 jul 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transacciones
    • 10 jul 2004Registro de un cargo (395)
    • 20 ene 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creado el 02 may 2003
    Entregado el 15 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 15 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 23 mar 2001
    Entregado el 03 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 03 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 06 ene 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 27 oct 2000
    Entregado el 01 nov 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 01 nov 2000Registro de un cargo (395)
    • 12 nov 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 jul 2020Inicio de la liquidación
    13 ene 2022Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Profesional
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Profesional
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0