HUMYNE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHUMYNE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04036104
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HUMYNE LIMITED?

    • Clubes con licencia (56301) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
    • Otras actividades recreativas y de entretenimiento n.c.p. (93290) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

    ¿Dónde se encuentra HUMYNE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    229 Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HUMYNE LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PAGESCHOOL LIMITED18 jul 200018 jul 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HUMYNE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ene 2020

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HUMYNE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Comptes modifiés d'exonération totale établis au 31 ene 2020

    7 páginasAAMD

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2020

    8 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 ene 2019

    10 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 29 abr 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 jul 2018 au 31 ene 2019

    1 páginasAA01

    Cancelación total de la carga 7

    2 páginasMR04

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 jul 2017

    10 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Andrew Timothy Balman el 09 mar 2018

    2 páginasCH01

    Modification des détails de Mr Andrew Timothy Balman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mar 2018

    2 páginasPSC04

    Domicilio social registrado cambiado de 105-107 Beverley Road Hull East Yorkshire HU3 1TS a 229 Spring Bank Hull HU3 1LR el 10 oct 2017

    1 páginasAD01

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Comptes modifiés d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 jul 2016

    7 páginasAAMD

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2016

    8 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Andrew Timothy Balman el 20 feb 2017

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Timothy Balman el 20 feb 2017

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 18 jul 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2015

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 jul 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital31 jul 2015

    Estado de capital el 31 jul 2015

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr Andrew Timothy Balman el 19 jun 2015

    2 páginasCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 jul 2014

    8 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de HUMYNE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Secretario
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    British71928480002
    BALMAN, Andrew Timothy
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    Director
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    EnglandBritish139738340005
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Director
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    EnglandBritish71928480002
    BALMAN, Andrew
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    Secretario
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    British60609250001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Secretario designado corporativo
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Director designado corporativo
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de HUMYNE LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Mr Andrew Timothy Balman
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    18 jul 2016
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    No
    Nacionalidad: British
    País de residencia: England
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene HUMYNE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 26 ene 2010
    Entregado el 29 ene 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The wellington club, wellington lane, kingston upon hull t/n HS171063 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 29 ene 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 17 oct 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 nov 2009
    Entregado el 11 dic 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 11 dic 2009Registro de un cargo (MG01)
    Deed of debenture
    Creado el 22 sept 2003
    Entregado el 27 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    105-107 beverley road kingston upon hull HU3 1TS fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets prestn & future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Coors Brewers Limited
    Transacciones
    • 27 sept 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal charge
    Creado el 04 jul 2003
    Entregado el 09 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a the welly club 105-107 beverley road hull HU3 1TS. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 09 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 11 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 15 may 2003
    Entregado el 24 may 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 may 2003Registro de un cargo (395)
    • 27 nov 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creado el 24 may 2001
    Entregado el 31 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The f/h property k/a 105-107 beverley road hull (now k/a the wellington club) t/n HS171063. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 31 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 07 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 05 mar 2001
    Entregado el 13 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 13 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 16 ago 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0