BARRACUDA INNS LIMITED

BARRACUDA INNS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBARRACUDA INNS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04036148
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BARRACUDA INNS LIMITED?

    • Pubs y bares (56302) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra BARRACUDA INNS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Benson House 33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    West Yorkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BARRACUDA INNS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BARRACUDA PUB COMPANY PLC20 sept 200020 sept 2000
    STEELDEW PLC18 jul 200018 jul 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BARRACUDA INNS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 sept 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BARRACUDA INNS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Informe de progreso del administrador hasta 19 abr 2013

    19 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 08 abr 2013

    19 páginas2.24B

    Aviso de cambio de la administración a la disolución el 08 abr 2013

    19 páginas2.35B

    Notificación de la aprobación presunta de las propuestas

    1 páginasF2.18

    Declaración de la propuesta del administrador

    82 páginas2.17B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    6 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de Lunar House Fieldhouse Lane Globe Park Marlow Bucks SL7 1LW el 31 oct 2012

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Se ha descontinuado la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS40

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Jane Teresa Biss como director el 15 jun 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christian Keen como secretario el 18 may 2012

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Vardigans como director el 18 may 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Robert Mcquater como director el 18 may 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Vardigans como secretario el 18 may 2012

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 31 oct 2011 avec liste complète des actionnaires

    8 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 nov 2011

    Estado de capital el 09 nov 2011

    • Capital: GBP 50,000
    SH01

    Cambio de datos del director Mr. Simon Geoffrey Vardigans el 08 nov 2011

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr. Richard Peter Stringer el 08 nov 2011

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 18 jul 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Mr. Simon Geoffrey Vardigans como secretario

    2 páginasAP03

    Nombramiento de Mr. Simon Geoffrey Vardigans como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nick Morgan como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Nick Morgan como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 25 sept 2010

    13 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de BARRACUDA INNS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KEEN, Christian
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House 33
    West Yorkshire
    Secretario
    Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Benson House 33
    West Yorkshire
    169292460001
    PRICE, Stephen Vincent
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    Director
    Southview
    1 Earnshaw Barns Middlewich Road
    CW10 9NE Byley
    Cheshire
    EnglandBritish103543030001
    STRINGER, Richard Peter
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Agraria Road
    GU2 4LG Guildford
    68
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish150670420001
    FEARN, Timothy Harris
    5 Morelands Grove
    GL1 5LR Gloucester
    Secretario
    5 Morelands Grove
    GL1 5LR Gloucester
    British99046990001
    MORGAN, Nicholas Mark
    53 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Secretario
    53 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British106335450001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    England
    Secretario
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    England
    British44988510001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secretario designado corporativo
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BISS, Jane Teresa
    Inglenook Vicarage Lane
    Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    Director
    Inglenook Vicarage Lane
    Laleham
    TW18 1UE Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish51632690001
    BOOTH, Victoria
    19 Crossways
    HP4 3NH Berkhamsted
    Director
    19 Crossways
    HP4 3NH Berkhamsted
    EnglandBritish106185220001
    FEARN, Timothy Harris
    5 Morelands Grove
    GL1 5LR Gloucester
    Director
    5 Morelands Grove
    GL1 5LR Gloucester
    EnglandBritish99046990001
    JONES, Graham Colin
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    Director
    Clive Lodge
    Wellington Square
    GL50 4JU Cheltenham
    Gloucestershire
    British95950700001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Director designado
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MCQUATER, Mark Robert
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    Director
    Lashbrook Lodge
    New Road Shiplake
    RG9 3LH Henley
    Oxfordshire
    United KingdomBritish72099650001
    MORGAN, Nicholas Mark
    53 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    53 Dukes Wood Drive
    SL9 7LJ Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish106335450001
    PHELAN, Kieran Gerard
    107 Monton Road
    M30 9HQ Eccles
    Manchester
    Director
    107 Monton Road
    M30 9HQ Eccles
    Manchester
    EnglandBritish111125520001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Director designado
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    VARDIGANS, Simon Geoffrey
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    Director
    Mayfield Avenue
    Chiswick
    W4 1PN London
    19
    United Kingdom
    EnglandBritish44988510001

    ¿Tiene BARRACUDA INNS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 10 jul 2009
    Entregado el 16 jul 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge.
    Breve descripción
    The l/h property k/a academy 140A church street preston t/no LAN26241. For further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 jul 2009Registro de un cargo (395)
    Deed of accession
    Creado el 28 jun 2005
    Entregado el 16 jul 2005
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for the Secured Parties) (the Securitytrustee)
    Transacciones
    • 16 jul 2005Registro de un cargo (395)
    Supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 18TH july 2000
    Creado el 14 dic 2000
    Entregado el 23 dic 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 23 dic 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A supplemental deed dated 22 september 2000 to a composite guarantee and debenture dated 18 july 2000 and made between the (1) the company (2) the existing charging companies (as defined) and (3) ppmv nominees limited
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 05 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations which as at 22 september 2000 owing or incurred in any manner whatsoever to the security beneficiaries (as defined) by any group company whether pursuant to the guarantee or otherwise whether solely or jointly with any other person including all liabilities from time to time assumed or incurred by the security beneficiaries at the request of an group company
    Breve descripción
    The deed contains covenants for further assurance and a negative pledge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Ppmv Nominees Limited
    Transacciones
    • 05 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 19 dic 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A charge dated 22 september 2000 relating to the entire issue share capital from time to time of the ambishus pub company PLC and made between the company and ppmv nominees limited as security trustee
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 05 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations owing or incurred in any manner whatsoever to the security beneficiaries (as defined) by any group company and whether or not the security trustee shall have been an original party to the relevant transaction
    Breve descripción
    The chargor as continuing security for the payment and discharge of the secured obligations (as defined) charges the charges property to the security trustee (as defined) the charge contains covenants for further assurance and a negative pledge.
    Personas con derecho
    • Ppmv Nomiees Limited
    Transacciones
    • 05 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Supplemental deed (to a composite guarantee and debenture dated 18 july 2000)
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 05 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee by any group company whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descripción
    Anglers rest 93 richmond park road 54 to 60 (even) richmond park drive sheffield S13 8HR - SYK158084 (l); banque mansfield 1 market place mansfield NG18 1HU - NT271757 (f); bar mondo low fell 508-514 durham road low fell gateshead NE9 6HU - TY358735 (f) for full details of all property charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transacciones
    • 05 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Charge relating to the entire issued share capital from time to time of the ambishus pub company PLC
    Creado el 22 sept 2000
    Entregado el 03 oct 2000
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All the company's property and rights in and to the shares and securities and derivative assets in the ambishus pub company PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 oct 2000Registro de un cargo (395)
    • 29 jul 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene BARRACUDA INNS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    08 abr 2013Fin de la administración
    27 sept 2012Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    David Peter Hurst
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Profesional
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0