HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED

HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa 04039240
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2017

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Simon Walker como secretario el 26 may 2017

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Alice Hermione Laura Ambrose-Thurman como secretario el 26 may 2017

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016

    2 páginasAA

    Nombramiento de Mrs Louise Bassett como director el 01 ago 2016

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 24 jul 2016 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Simon Walker como director el 01 ago 2016

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Alice Hermione Laura Ambrose-Thurman como secretario el 01 ago 2016

    2 páginasAP03

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2015, aucune liste de membres fournie

    2 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2014, aucune liste de membres fournie

    2 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2013, aucune liste de membres fournie

    2 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    2 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2012, aucune liste de membres fournie

    2 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2011

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 24 jul 2011, aucune liste de membres fournie

    10 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Isobel Hargrave como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Simon Walker como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Crawford como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WALKER, Simon
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    Secretario
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    232400610001
    BASSETT, Louise
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    Director
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    EnglandBritish209599290001
    AMBROSE-THURMAN, Alice Hermione Laura
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    Secretario
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    211664000001
    HOWDEN, Charles Martin
    2 Brackendale Road
    Belmont
    DH1 2AD Durham
    County Durham
    Secretario
    2 Brackendale Road
    Belmont
    DH1 2AD Durham
    County Durham
    British97385790001
    JARVIS, Jonathan Edward Madison
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    Secretario
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    British65969460001
    KELLY, Kevin Joseph
    15 Aspen Close Biddicks Woods
    Shiney Row
    DH4 7TU Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Secretario
    15 Aspen Close Biddicks Woods
    Shiney Row
    DH4 7TU Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British103040910001
    RILEY, Richard Paul
    29 Wrens Avenue
    DY4 8AF Tipton
    West Midlands
    Secretario
    29 Wrens Avenue
    DY4 8AF Tipton
    West Midlands
    British73947670001
    ALLCROFT, Jean
    7 Bleasdale Crescent
    Penshaw
    DH4 7RQ Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    7 Bleasdale Crescent
    Penshaw
    DH4 7RQ Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish122147880001
    ALLSOPP, David Thomas
    Manor Drive
    Hilton
    TS15 9LE Yarm
    7
    Cleveland
    England
    Director
    Manor Drive
    Hilton
    TS15 9LE Yarm
    7
    Cleveland
    England
    United KingdomBritish75344650003
    BLACKBURN, James
    51 Lilywhite Terrace
    Easington Lane
    DH5 OHF Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    51 Lilywhite Terrace
    Easington Lane
    DH5 OHF Sunderland
    Tyne & Wear
    British122147750001
    CALVERT, John William
    53 Abbey Drive
    Sunniside Estate
    DH4 5LA Houghton Le Spring
    Tyne And Wear
    Director
    53 Abbey Drive
    Sunniside Estate
    DH4 5LA Houghton Le Spring
    Tyne And Wear
    EnglandBritish75523820001
    COLLINS, Peter Donald Bruce, Dr
    Glenside
    Burn Lane, Hetton
    DH5 9JG Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    Glenside
    Burn Lane, Hetton
    DH5 9JG Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish146104400001
    CRAWFORD, David
    The Red House
    Wintrick
    NE65 9QN Felton
    Northumberland
    Director
    The Red House
    Wintrick
    NE65 9QN Felton
    Northumberland
    EnglandBritish154459870001
    FOX, James Spears Fishburn
    42 Clydesdale Street
    Peat Carr Estate
    DH5 0DE Hetton Le Hole
    Tyne And Wear
    Director
    42 Clydesdale Street
    Peat Carr Estate
    DH5 0DE Hetton Le Hole
    Tyne And Wear
    British75344260001
    HALL, Lesley Anne
    3 Marne Street
    Shiney Row
    DH4 7AG Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    3 Marne Street
    Shiney Row
    DH4 7AG Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British75343810003
    HALL NELSON, Bridget Jacqueline
    45 Queensway
    DH5 8EW Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    45 Queensway
    DH5 8EW Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British75344770001
    HARGRAVE, Isobel
    5 York Crescent
    DH5 9LL Hetton Le Hole
    Tyne & Wear
    Director
    5 York Crescent
    DH5 9LL Hetton Le Hole
    Tyne & Wear
    EnglandBritish75344140001
    HERON, Juliana
    Low Downs Road
    Hetton Le Hole
    DH5 9AW Houghton Le Spring
    26
    Tyne & Wear
    Director
    Low Downs Road
    Hetton Le Hole
    DH5 9AW Houghton Le Spring
    26
    Tyne & Wear
    EnglandBritish75344360001
    JARVIS, Jonathan Edward Madison
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    Director
    Flat 1 Mayfair Court
    15 Park Hill Rise
    CR0 5RU Croydon
    British65969460001
    KHAN, Yousof
    31 Coopers Walk
    CV8 3JB Bubbenhall
    Warwickshire
    Director
    31 Coopers Walk
    CV8 3JB Bubbenhall
    Warwickshire
    British73947560001
    MOSES, Annette Michelle
    97 Abbey Drive
    Sunniside Estate
    DH4 5LB Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    97 Abbey Drive
    Sunniside Estate
    DH4 5LB Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritish90723750001
    MTANGO, Sarah
    Flat 5 Fountside Oakdale Road
    Nether Edge
    S7 1SN Sheffield
    Yorkshire
    Director
    Flat 5 Fountside Oakdale Road
    Nether Edge
    S7 1SN Sheffield
    Yorkshire
    British75344300005
    OHARA, John Eric
    1 The Oval
    Houghton Le Spring
    DH4 5DB Tyne & Wear
    Director
    1 The Oval
    Houghton Le Spring
    DH4 5DB Tyne & Wear
    British75344710001
    RICHARDSON, Dennis, Councillor
    Roecroft
    Station Avenue South, Fencehouses
    DH4 6HN Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    Roecroft
    Station Avenue South, Fencehouses
    DH4 6HN Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    EnglandBritish80960990001
    RILEY, Richard Paul
    29 Wrens Avenue
    DY4 8AF Tipton
    West Midlands
    Director
    29 Wrens Avenue
    DY4 8AF Tipton
    West Midlands
    British73947670001
    ROBERTS, Stephen James
    34 Oakfield Drive
    Killingworth
    NE12 6YY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    34 Oakfield Drive
    Killingworth
    NE12 6YY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish68014050001
    ROLPH, Kathryn Margaret
    3 Atherton Drive
    Chilton Moor
    DH4 6TA Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Director
    3 Atherton Drive
    Chilton Moor
    DH4 6TA Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British94226650001
    SMITH, Patrick Owen
    15 Chipchase Court
    Woodstone Village
    DH4 6TT Houghton Le Spring
    Durham
    Director
    15 Chipchase Court
    Woodstone Village
    DH4 6TT Houghton Le Spring
    Durham
    British112194160001
    SMITH, Steven Barry
    Flat 11 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1W 2YG London
    Director
    Flat 11 Dundee Court
    73 Wapping High Street
    E1W 2YG London
    British69423810001
    SNOWDON, David
    94 Roche Court
    Glebe
    NE38 7PN Washington
    Tyne & Wear
    Director
    94 Roche Court
    Glebe
    NE38 7PN Washington
    Tyne & Wear
    EnglandBritish81627850001
    SWEENEY, Peter John
    78 Queen Alexandra Road
    SR2 9HW Sunderland
    Tyne & Wear
    Director
    78 Queen Alexandra Road
    SR2 9HW Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish73482920001
    TATE, Richard David, Councillor
    25 Ennerdale Street
    DH5 0DT Hetton Le Hole
    Tyne & Wear
    Director
    25 Ennerdale Street
    DH5 0DT Hetton Le Hole
    Tyne & Wear
    EnglandBritish194629840001
    WALKER, Simon
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    Director
    2 Emperor Way
    Sunderland
    SR3 3XR
    United KingdomBritish135780140001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    24 jul 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene HOUGHTON & HETTON HOUSING COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A security agreement
    Creado el 31 jul 2001
    Entregado el 06 ago 2001
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations and liabilities owed by the borrowers or any of them to each finance party under the finance documents
    Breve descripción
    By way of first legal mortgage all the property referred to in schedule 1 of the security agreement together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale and the benefit of any covenants for title.. By way of first fixed charge all fixed plant and machinery..all benefits in respect of the insurances... See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Prudential Trustee Company Limited (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 06 ago 2001Registro de un cargo (395)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0