CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED

CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04047384
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED?

    • Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios

    ¿Dónde se encuentra CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Dalton Building Maxwell Avenue
    Harwell Science And Innovation Campus
    OX11 OQT Didcot
    Oxon
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    4 páginasDS01

    Cese del nombramiento de David Alan Hellicar como director el 07 nov 2012

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 04 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital07 sept 2012

    Estado de capital el 07 sept 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 ago 2011

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 ago 2010

    5 páginasAA

    Exercice comptable précédent raccourci du 31 mar 2011 au 31 ago 2010

    1 páginasAA01

    Misceláneos

    Section 519
    1 páginasMISC

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2010

    18 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de Colonial House Swinemoor Lane Beverley East Yorkshire HU17 0LS England el 18 jun 2010

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Kenneth Mckenzie como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de David Alan Hellicar como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrew Smith como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Adrian Jolly como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Rockett como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Lloyd-Jones como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Mark Taylor como director

    1 páginasTM01

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    Nombramiento de Mr Andrew Mark Lloyd-Jones como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Andrew John Smith como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Matthew Ian Rockett como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Iain Johnston como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MCKENZIE, Kenneth Alan
    Harwell Science And Innovation Centre
    OX11 0QT Didcot
    Dalton Building Maxwell Avenue
    Oxfordshire
    Director
    Harwell Science And Innovation Centre
    OX11 0QT Didcot
    Dalton Building Maxwell Avenue
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManaging Director44321140002
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Secretario
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    UkDirector702270001
    MAUGHAN, Anna
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    Secretario
    404 Chester Road
    Boldmere
    B73 5BS Sutton Coldfield
    British53071850001
    SIMPSON, Anthony Harry
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    Secretario
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    BritishDirector71935470001
    THOMAS, Caroline Emma Roberts
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    Secretario
    5 Broomsleigh Street
    NW6 1QQ London
    British154322040001
    KEY LEGAL SERVICES (SECRETARIAL) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Secretario designado corporativo
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004240001
    BELK, Andrew John
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    Director
    Pen Plannau
    Moelfre
    SY10 7QL Llansilin
    North Wales
    BritishDirector65603000003
    CABLE, Richard John
    8 Ambleside Walk
    LS22 6DP Wetherby
    West Yorkshire
    Director
    8 Ambleside Walk
    LS22 6DP Wetherby
    West Yorkshire
    BritishMarketing & Bus Dev94183400001
    CARLISLE, Ian
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    Director
    The Clock House
    West End Road Box End
    MK43 8RT Kempston Rural
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector146715900001
    FORD, Simon
    9 Eversfield Close
    Kingswood
    HU7 3EQ Hull
    North Humberside
    Director
    9 Eversfield Close
    Kingswood
    HU7 3EQ Hull
    North Humberside
    BritishDirector Of External Operation117421040001
    HELLICAR, David Alan
    Maxwell Avenue
    Harwell Science And Innovation Centre
    OX11 0QT Didcot
    Dalton Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Director
    Maxwell Avenue
    Harwell Science And Innovation Centre
    OX11 0QT Didcot
    Dalton Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinancial Director80280850001
    JOHNSTON, Iain
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    Director
    3 Scholes Park Road
    YO12 6RE Scarborough
    North Yorkshire
    United KingdomUkAccountant702270001
    JOLLY, Adrian Richard
    268 Moorhouse Road
    HU5 5PL Hull
    East Yorkshire
    Director
    268 Moorhouse Road
    HU5 5PL Hull
    East Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Director87664160001
    LETHEREN, Ralph
    44 Lichfield Close
    HU17 8PX Beverley
    East Yorkshire
    Director
    44 Lichfield Close
    HU17 8PX Beverley
    East Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director61272570001
    LLOYD-JONES, Andrew Mark
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    Director
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector149155620001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    Director
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    BritishBritishAccountant146169560001
    ROCKETT, Matthew Ian
    Trent Walk, Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    Director
    Trent Walk, Welton Grange
    HU15 1GF Brough
    7
    East Yorkshire
    BritishBritishAccountant146169560001
    SCOTT, Charlie Richard
    11 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    11 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector117420980001
    SIMPSON, Anthony Harry
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    Director
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    BritishDirector71935470001
    SIMPSON, Barbara Ann
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    Director
    38 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QA Rugeley
    Staffordshire
    BritishDirector71935580001
    SMITH, Andrew John
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    Director
    Swinemoor Lane
    HU17 0LS Beverley
    Colonial House
    East Yorkshire
    England
    UkBritishDirector149018750001
    SMITH, Philip Norman
    44 Copandale Road
    HU17 7BW Beverley
    North Humberside
    Director
    44 Copandale Road
    HU17 7BW Beverley
    North Humberside
    BritishCompany Director16903250003
    TAYLOR, Mark Andrew
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    Director
    Westlands
    Queensgate
    HU17 8NE Beverley
    United KingdomBritishDirector95264700003
    TEMPLETON, Jeremy
    7 Highland Way
    WS15 2HX Rugeley
    Staffordshire
    Director
    7 Highland Way
    WS15 2HX Rugeley
    Staffordshire
    BritishOperations Director81985220001
    KEY LEGAL SERVICES (NOMINEES) LIMITED
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    Director designado corporativo
    20 Station Road
    Radyr
    CF15 8AA Cardiff
    900004230001

    ¿Tiene CONCEPT DOCUMENT RECOVERY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Composite guarantee and debenture
    Creado el 24 sept 2009
    Entregado el 14 oct 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from ingleby (1823) limited to the noteholders on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the property and assets, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Jonathan Simpson-Dent (As Security Trustee)
    Transacciones
    • 14 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    Debenture
    Creado el 24 sept 2009
    Entregado el 03 oct 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Hsbc Bank PLC
    Transacciones
    • 03 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    Composite guarantee and debentures
    Creado el 24 sept 2009
    Entregado el 02 oct 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transacciones
    • 02 oct 2009Registro de un cargo (MG01)
    An omnibus leter of set-off
    Creado el 11 jul 2003
    Entregado el 23 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company and/or chem-dry U.K. limited to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 23 jul 2003Registro de un cargo (395)
    • 22 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 03 oct 2001
    Entregado el 09 oct 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 09 oct 2001Registro de un cargo (395)
    • 23 mar 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0