ENERGIS MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ENERGIS MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04050367 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
- Otras actividades de telecomunicaciones (61900) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| CITRUSCOVE LIMITED | 10 ago 2000 | 10 ago 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 16 may 2017
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Tarek Sayed como director el 05 oct 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Richard Mullock como director el 05 oct 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Royston Kinch como director el 30 nov 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Kerry Phillip como director el 13 ene 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Vodafone Corporate Secretaries Limited como director el 12 ene 2015 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||||||
Nombramiento de Richard Mullock como director el 12 ene 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Nombramiento de Kerry Phillip como director el 01 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Philip Stephen James Davis como director el 01 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de Worldwide House Western Road Bracknell Berkshire RG12 1RW United Kingdom | 1 páginas | AD02 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2013 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| SAYED, Tarek | Director | Cypress Court GU25 4TB Virginia Water 1 England England | United Kingdom | British | 215751210001 | |||||||||
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Director corporativo | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Secretario | 7th Floor The Point 37 North Wharf Road W2 1LA London | British | 122128470001 | ||||||||||
| HANSCOMB, Heledd Mair | Secretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
| MCKELVIE, Andrew Laurence | Secretario | 110 Osborne Road BN1 6LU Brighton East Sussex | British | 60126680002 | ||||||||||
| MOORE, Paul Anthony | Secretario | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152562960001 | |||||||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
| COOPER, Nicholas Ian | Director | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | 122128470002 | |||||||||
| DAVIS, Philip Stephen James | Director | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135958960001 | |||||||||
| GIBSON, Ian Jeffrey | Director | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | 78528840005 | |||||||||
| GRABINER, Michael | Director | 35 Uphill Road Mill Hill NW7 4RA London | United Kingdom | British | 82032360001 | |||||||||
| HIBBERT, John Christopher | Director | The Moat House Hoxne IP21 5AZ Eye Suffolk | British | 6236200001 | ||||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Director | 7 Wentworth House 12 Chelsea Embankment SW3 4LE London | British | 108268030002 | ||||||||||
| JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Director | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | 108268030003 | |||||||||
| KINCH, Alan Royston | Director | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | 163334420001 | |||||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Director designado | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||||||
| MORGAN, Nicola Jane | Director | 58 Farnham Road GU2 4PE Guildford Surrey | British | 123399870001 | ||||||||||
| MULLOCK, Richard | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 193570430001 | |||||||||
| NORMAN, Archibald John | Director | 6th Floor Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London | British | 69649430003 | ||||||||||
| O'HARE, Eamonn | Director | Oldbury Court Houston Way RG45 6BY Crowthorne Berkshire | British | 90680120001 | ||||||||||
| PHILLIP, Kerry | Director | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | 185033430001 | |||||||||
| PLUTHERO, John | Director | Lakeside House Cain Road RG12 1XL Bracknell Berkshire | United Kingdom | British | 123920610001 | |||||||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Director designado | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
| TRENT, William Edward James | Director | 57 Rosslyn Hill Hampstead NW3 5UQ London | United Kingdom | British | 81249170001 | |||||||||
| WICKHAM, David Ian | Director | Galleons 16 Homestead Road BR6 6HW Orpington Kent | England | British | 68123400001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ENERGIS MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energis Holdings Limited | 06 abr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene ENERGIS MANAGEMENT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of debenture and assignment | Creado el 16 jul 2002 Entregado el 24 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0