MXR HOLDINGS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MXR HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04052195 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MXR HOLDINGS LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra MXR HOLDINGS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 30 Leicester Square WC2H 7LA London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MXR HOLDINGS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MXR HOLDINGS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 4 páginas | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | SH20 | ||||||||||
Estado de capital el 15 mar 2018
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Beak como secretario el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cambio de datos del director John Williams el 30 dic 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2017 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Paul Eaton como director el 12 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 jun 2017 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Global Radio Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Notification de Real and Smooth Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 23 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Darren David Singer como director el 11 dic 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Gabriel Miron como director el 11 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Beak como secretario el 11 dic 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2015 | 15 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Ronald Potterell como secretario el 30 sept 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Clive Ronald Potterell como director el 30 sept 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Stephen Gabriel Miron como director el 14 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Damien Connole como director el 14 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 14 ago 2015 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MXR HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDING, Will | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 England | United Kingdom | British | 119644700001 | |||||
| HOLEBROOK, Stephen | Director | Crawley Court SO21 2QA Winchester Hampshire United Kingdom | England | British | 139930130001 | |||||
| HOLROYD, David John | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | United Kingdom | British | 170744160001 | |||||
| SINGER, Darren David | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | England | British | 159918310001 | |||||
| WILLIAMS, John | Director | Apple Industrial Estate Whittle Avenue PO15 5SX Fareham Radio House Hampshire United Kingdom | England | British | 110937790001 | |||||
| BEAK, Jonathan | Secretario | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | 203911830001 | |||||||
| POTTERELL, Clive Ronald | Secretario | Leicester Square WC2H 7LA London 30 England | British | 3182530002 | ||||||
| POTTERELL, Clive Ronald | Secretario | Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue KT7 0HF Thames Ditton Surrey | British | 3182530002 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretario designado corporativo | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ABBOTT, Judith Lesley, Dr | Director | The Pines Meadow Bank CM3 2DE Hatfield Peverel Essex | England | British | 147589030001 | |||||
| ARCHER, John | Director | 26 Kingsdown Avenue LU2 7BU Luton Bedfordshire | United Kingdom | British | 76245390001 | |||||
| BAILEY, Clive Henry | Director | Laburnum House 289 Rectory Road Hawkwell SS5 4LA Hockley Essex | England | British | 96018870001 | |||||
| BENNETT, Christopher James | Director | Fairmile Corner Cottage Portsmouth Road KT11 1BG Cobham Surrey | England | English | 94366880001 | |||||
| BERRY, Patrick | Director | 19 Sunset Road Camberwell SE5 8EA London | England | British | 19720880002 | |||||
| BOWRON, Shaun | Director | 18 Woodlands Darras Hall NE20 9EU Ponteland Northumberland | British | 93955470001 | ||||||
| BRIDGE, Gary Robert | Director | Kings Place 90 York Way N1P 2AJ London Gmg Radio Holdings PO BOX 68164 United Kingdom | United Kingdom | British | 162426100001 | |||||
| BROWNROUT, Melanie | Director | 74 Forthbridge Road SW11 5NY London | American | 83259700001 | ||||||
| COLE, Simon Andrew | Director | Sutherland Place W2 5BZ London 17 | United Kingdom | British | 75273740005 | |||||
| CONNOLE, Michael Damien | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 England | England | Irish | 47934750001 | |||||
| CRAMTON, Kevin | Director | 27 The Marlowes NW8 6NB St Johns Wood London | United States | 83259520001 | ||||||
| DAVIDSON, Bruce | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 England | Britain | British | 74737150003 | |||||
| DEEGAN, Matthew Simon | Director | Flat 5 8 Ashmount Road Highgate N19 3BJ London | England | British | 125393900001 | |||||
| DONALD, Jennifer Helen | Director | 7 Woodwarde Road Dulwich SE22 8UN London | New Zealand | 74734800001 | ||||||
| EATON, Paul | Director | Oxford Road SO21 3JG Sutton Scotney Orchard House Hampshire | England | British | 130619880001 | |||||
| EGGLESTON, Andrew | Director | Flat 8 The Lab Building 177 Rosebery Avenue EC1R 4TW London | British | 74736760002 | ||||||
| EVANS, Mark Roy | Director | 17 Carless Avenue B17 9BN Birmingham West Midlands | England | British | 54693600002 | |||||
| EVERITT, Colin David | Director | Waterfront Quay M50 3XW Salford Quays Laser House Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 140868130001 | |||||
| EVERITT, Colin David | Director | Leicester Square WC2H 7LA London 30 England | United Kingdom | British | 140868130001 | |||||
| FAIRBURN, Paul Martin | Director | 9 Tansley Gardens Dorridge B93 8UB Solihull West Midlands | England | British | 43039880003 | |||||
| FALCON, John Christopher | Director | The Chase BR1 3DF Bromley 54 Kent | England | British | 122207130002 | |||||
| FLANAGAN, Mark Simon | Director | 14 Denehurst Gardens W3 9QY London | British | 69776160004 | ||||||
| HIND, Gillian Mary | Director | The Pack House 72 Ashwell Road Bygrave SG7 5EA Baldock Hertfordshire | British | 85446790001 | ||||||
| HIND, Gillian Mary | Director | 47 Balham Grove SW12 8AZ Balham London | British | 77370850001 | ||||||
| HOLEBROOK, Stephen | Director | Chilworth Road Chilworth SO16 7JZ Southampton Holly Lodge Hampshire | England | British | 139930130001 | |||||
| KASPROWSKI, Jorg Heinz | Director | Meads Cottage The Meads CM24 8QA Stansted Mountfitchet Essex | British | 90354440001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MXR HOLDINGS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real And Smooth Limited | 06 abr 2016 | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Global Radio Holdings Limited | 06 abr 2016 | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0