OXUS GOLD PLC.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaOXUS GOLD PLC.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa 04056219
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de OXUS GOLD PLC.?

    • Extracción de otros minerales metálicos no ferrosos (07290) / Explotación de minas y canteras

    ¿Dónde se encuentra OXUS GOLD PLC.?

    Dirección de la sede social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de OXUS GOLD PLC.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    OXUS MINING PLC08 jun 200108 jun 2001
    GOLSKI LIMITED01 dic 200001 dic 2000
    GOLSKI LIMITED01 dic 200001 dic 2000
    INTERCEDE 1642 LIMITED21 ago 200021 ago 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de OXUS GOLD PLC.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2014

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para OXUS GOLD PLC.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de cambio de la administración a la disolución

    30 páginasAM23

    Informe de progreso del administrador

    30 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    23 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    23 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    22 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    21 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    20 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador

    20 páginasAM10

    Informe de progreso del administrador hasta 08 dic 2016

    11 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador

    13 páginasAM10

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Cese del nombramiento de Oliver Charles Prior como director el 01 ene 2017

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Richard Barry Shead como director el 04 ene 2017

    2 páginasTM01

    Informe de progreso del administrador hasta 26 jul 2016

    10 páginas2.24B

    Resultado de la reunión de acreedores

    2 páginas2.23B

    Declaración de asuntos con el formulario 2.14B

    7 páginas2.16B

    Domicilio social registrado cambiado de Prince Frederick House, 35-39 Maddox Street Maddox Street London W1S 2PP a 55 Baker Street London W1U 7EU el 09 feb 2016

    2 páginasAD01

    Nombramiento de un administrador

    1 páginas2.12B

    Cancelación total de la carga 4

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 3

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    2 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de OXUS GOLD PLC.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    The Cottage
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    The Cottage
    Middlesex
    United Kingdom
    150422970001
    CHANDHOK, Jyoti
    Southover
    Woodside Park
    N12 7ES London
    52
    Secretario
    Southover
    Woodside Park
    N12 7ES London
    52
    BritishAccountant136476060001
    KIPPS, Jonathan Arthur
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    Secretario
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishFinance Director86182020001
    TAYLOR, Kenneth Dudley
    25 Belgrave Manor
    Brooklyn Road
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    Secretario
    25 Belgrave Manor
    Brooklyn Road
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    AustralianFinancial Officer73399270001
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    Secretario
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    BritishAccountant47021800001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secretario designado corporativo
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BECKETT, Michael Ernest
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    Director
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    BritishDirector118661100001
    COOPER, Charles Arthur
    360 N Wilton Road
    06840 New Canaan
    Connecticut
    Usa
    Director
    360 N Wilton Road
    06840 New Canaan
    Connecticut
    Usa
    AmericanDirector48634460001
    DE VILLIERS, Michael John
    Lorien
    Elms Road
    RG27 9DX Hook
    Hampshire
    Director
    Lorien
    Elms Road
    RG27 9DX Hook
    Hampshire
    EnglandBritishDirector72809180002
    DEASY, Patrick
    Flat B 47 Hartham Road
    N7 9JJ London
    Director
    Flat B 47 Hartham Road
    N7 9JJ London
    BritishSolicitor61686750001
    DJALALOV, Miradil Sabitovich
    Sh. Islamov Street 26
    Tashkent
    100115
    Uzbekistan
    Director
    Sh. Islamov Street 26
    Tashkent
    100115
    Uzbekistan
    UzbekDirector127492550001
    DONALD, John Clow
    21 The Boulevardes
    Patterson Lakes
    Melbourne
    3197
    Australia
    Director
    21 The Boulevardes
    Patterson Lakes
    Melbourne
    3197
    Australia
    BritishDirector127376400001
    DONALD, John Clow
    6 Derby Court
    The Promenade
    IM9 1BG Castletown
    Isle Of Man
    Director
    6 Derby Court
    The Promenade
    IM9 1BG Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishCompany Director86487580001
    HILL, Graham David
    Audern Road
    DN16 3LH Scunthorpe
    19
    South Humberside
    Director
    Audern Road
    DN16 3LH Scunthorpe
    19
    South Humberside
    BritishMining128201300001
    KAPPES, Daniel William
    1721 York Way
    Sparks
    Nevada
    89431
    Usa
    Director
    1721 York Way
    Sparks
    Nevada
    89431
    Usa
    AmericanMining Engineer86805130001
    KIPPS, Jonathan Arthur
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    Director
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishChartered Accountant86182020001
    MCBURNEY, James Ronald Gordon
    Luxemburg Gardens
    W6 7EA London
    4
    Director
    Luxemburg Gardens
    W6 7EA London
    4
    United KingdomUk Usa Dual CitizenDirector136300730001
    MCLEAN SUTHERLAND, Douglas
    5 Great Snoring Road
    NR21 0PG Hindringham
    Norfolk
    Director
    5 Great Snoring Road
    NR21 0PG Hindringham
    Norfolk
    BritishChartered Accountant101033050001
    NORTON, Darryl
    23 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane St Mary's Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Director
    23 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane St Mary's Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    BritishAlternate Director125664290001
    PAS, Guido Edward
    6 Chemin Du Mousseron
    Pregny-Chamesy
    Switzerland
    Director
    6 Chemin Du Mousseron
    Pregny-Chamesy
    Switzerland
    BelgianFinancier97587960001
    PRIOR, Oliver Charles
    Full Moon Barn
    Warren Road
    TN35 4AN Fairlight
    East Sussex
    Director
    Full Moon Barn
    Warren Road
    TN35 4AN Fairlight
    East Sussex
    Great BritainBritishConsultant127221690001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Director designado
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British900020860001
    SHEAD, Richard Barry
    Upper Berkeley Street
    W1H 5QJ London
    42
    United Kingdom
    Director
    Upper Berkeley Street
    W1H 5QJ London
    42
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector131162590003
    SHEAD, Richard Barry
    5 Buckland Place
    Bedfordview
    Gauteng 2007
    South Africa
    Director
    5 Buckland Place
    Bedfordview
    Gauteng 2007
    South Africa
    South AfricaDirector86349190001
    TREW, William James
    30a Arklow Road
    Bryanston
    Gauteng 2021
    South Africa
    Director
    30a Arklow Road
    Bryanston
    Gauteng 2021
    South Africa
    South African/BritishCompany Director87018470001
    TURNER, Roger William
    45 Greenmeads
    Westfield
    GU22 9QJ Woking
    Surrey
    Director
    45 Greenmeads
    Westfield
    GU22 9QJ Woking
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive Officer11594180001
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Director designado
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British900019540001
    WARRENDER, Anthony Michael
    Oak Ridge Farm
    PO BOX 1431
    IRISH Middleburg
    Virginia 20118
    Usa
    Director
    Oak Ridge Farm
    PO BOX 1431
    IRISH Middleburg
    Virginia 20118
    Usa
    BritishFinance Consulting48401540002
    WELLESLEY-WOOD, Mark Michael
    Dolphin House
    Hayes Lane, Slinfold
    RH13 7SN Horsham
    West Sussex
    Director
    Dolphin House
    Hayes Lane, Slinfold
    RH13 7SN Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishEngineer41874630004
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    Director
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant47021800001
    WYLIE, Gordon Ferguson
    64 7th Avenue
    Melville
    Gauteng 2092
    South Africa
    Director
    64 7th Avenue
    Melville
    Gauteng 2092
    South Africa
    BritishGeologist110835790001

    ¿Tiene OXUS GOLD PLC. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A mortgage over proceeds
    Creado el 26 jun 2012
    Entregado el 05 jul 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest from time to time in and to the proceeds (and all related rights) see image for full details.
    Personas con derecho
    • Gretton Limited
    Transacciones
    • 05 jul 2012Registro de un cargo (MG01)
    Priorities agreement
    Creado el 27 feb 2012
    Entregado el 15 mar 2012
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The proceeds. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Gretton Limited
    Transacciones
    • 15 mar 2012Registro de un cargo (MG01)
    Legal charge
    Creado el 11 mar 2009
    Entregado el 18 mar 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    £126,750 from time to time currently held on account.
    Personas con derecho
    • Autonomy Systems Limited
    Transacciones
    • 18 mar 2009Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 25 feb 2009
    Entregado el 28 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A first fixed equitable charge oto the landlord over the deposit balance given by the tenant with full title guarantee as continuing security for the secured liabilities. On the date of the rent deposit deed the tenant paid to the landlord £34,978 which was paid into the deposit account see image for full details.
    Personas con derecho
    • Berkeley Square Holdings Limited
    Transacciones
    • 28 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 25 feb 2009
    Entregado el 28 feb 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    A first fixed equitable charge over the deposit balance. See image for full details.
    Personas con derecho
    • Berkeley Square Holdings Limited
    Transacciones
    • 28 feb 2009Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creado el 10 nov 2008
    Entregado el 19 nov 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon, the charged account being: barclays bank PLC re oxus gold PLC, euro business premium account, numbered 55401133.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 19 nov 2008Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 22 ene 2007
    Entregado el 25 ene 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £37,235.26 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    All sums falling due pursuant to a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rbsi Custody Bank Limited and Rbsi Trust Company Limited Being the Trustees of the Hanoverproperty Unit Trust
    Transacciones
    • 25 ene 2007Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Rent deposit deed
    Creado el 11 may 2006
    Entregado el 18 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £37,235.26 and all other monies due or to become due
    Breve descripción
    All sums falling due pursuant to the lease dated 11TH may 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Rbsi Custody Bank Limited and Rbsi Trust Company Limited Being the Trustees of the Hanoverproperty Unit Trust
    Transacciones
    • 18 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over the oxus gold/oxus malta credit agreement
    Creado el 25 ene 2006
    Entregado el 03 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in each charged agreement being the oxus gold/oxus malta credit agreement,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nedbank Limited
    Transacciones
    • 03 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over the agf credit agreement
    Creado el 25 ene 2006
    Entregado el 03 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in each charged agreement being the agf credit agreement dated 17 july 2002 and amended and restated on 2 april 2003,. see the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nedbank Limited
    Transacciones
    • 03 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 25 ene 2006
    Entregado el 03 feb 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    With full title guarantee the securities being all shares listed in the charge including all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Nedbank Limited
    Transacciones
    • 03 feb 2006Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over bank account
    Creado el 07 ene 2005
    Entregado el 14 ene 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The chargor hereby charges with full title guarantee the deposit;. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (Trustee)
    Transacciones
    • 14 ene 2005Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed
    Creado el 17 jun 2003
    Entregado el 20 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The credit balance on the companies account at national westminster bank PLC (account number 41806492 sort code 01-00-08) including all monies to be paid into such account in accordance with the said deed.
    Personas con derecho
    • Haslemere Estates Public Limited
    Transacciones
    • 20 jun 2003Registro de un cargo (395)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over shares
    Creado el 17 jul 2002
    Entregado el 06 ago 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the borrower to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    By way of first fixed charge the securities (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Societe Generale (As Trustee for the Secured Parties)
    Transacciones
    • 06 ago 2002Registro de un cargo (395)
    • 03 nov 2009Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad gravada ha sido liberada (MG04)
    • 19 ene 2016Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene OXUS GOLD PLC. algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 ene 2016Inicio de la administración
    04 ene 2021Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Shane Crooks
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Profesional
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0