BL GAZELEY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | BL GAZELEY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | 04056302 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BL GAZELEY LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BL GAZELEY LIMITED?
| Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BL GAZELEY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BL/GAZELEY LIMITED | 21 nov 2000 | 21 nov 2000 |
| INTERCEDE 1632 LIMITED | 21 ago 2000 | 21 ago 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BL GAZELEY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BL GAZELEY LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BL GAZELEY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shane Roger Kelly como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel William John Godfrey como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 19 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2014 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Shane Roger Kelly como director el 22 abr 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Charles Berkoff como director el 22 abr 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Shane Roger Kelly como director el 22 abr 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stuart Charles Berkoff como director el 22 abr 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Michael John Forshaw como director el 05 dic 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 05 dic 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy Andrew Roberts el 06 ago 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Timothy Andrew Roberts el 25 nov 2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2013 avec liste complète des actionnaires | 19 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mahmood Iqbal Hasan como director el 26 jun 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2012 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 21 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mahmood Iqbal Hasan como director el 15 nov 2011 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 21 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 9 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BL GAZELEY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EKPO, Ndiana | Secretario | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | 1898090001 | |||||
| BOULTON, Jennie | Secretario | 45 Isaacson Drive Wavendon Gate MK7 7RQ Milton Keynes Buckinghamshire | British | 61656850002 | ||||||
| BRAINE, Anthony | Secretario | 21 Woodville Road Ealing W5 2SE London | British | 32809000002 | ||||||
| PHILP, Clive James | Secretario | Oakey Lane SE1 7HN London 25 United Kingdom | British | 140785910001 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
| SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | Flat 5, Chelston Court 14 Grove Road KT6 4DA Surbiton Surrey | British | 72249480002 | ||||||
| MITRE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | Mitre House 160 Aldersgate Street EC1A 4DD London | 900004680001 | |||||||
| BERKOFF, Stuart Charles | Director | Green Lane HA8 7QA Edgware 68 Middlesex | United Kingdom | British | 125709190002 | |||||
| BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | 152497530001 | |||||
| CARTER, Simon Geoffrey | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | 170891060001 | |||||
| DUGGAN, John | Director | The Stables Home Farm MK10 9AJ Milton Keynes Village Buckinghamshire | United Kingdom | British | 18472080002 | |||||
| FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 44 Kerris Way Lower Earley RG6 5UW Reading Berkshire | England | British | 1898090001 | |||||
| GODFREY, Nigel William John | Director | The Weather House MK18 5LX Shalstone Buckinghamshire | United Kingdom | United Kingdom | 73234830001 | |||||
| GOMERSALL, Peter Anthony | Director | 18 Chiswick Quay Hartington Road W4 3UR Chiswick | England | British | 12359850001 | |||||
| HASAN, Mahmood Iqbal | Director | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | England | British | 164450370001 | |||||
| KELLY, Shane Roger | Director | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | England | British | 179642130001 | |||||
| KELLY, Shane Roger | Director | Palace Street Cardinal Place SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | England | British | 179642130001 | |||||
| REDWOOD, Nicholas Paul Kenneth | Director | Avenue Road AL1 3QQ St Albans 6 Hertfordshire | United Kingdom | British | 107118750001 | |||||
| REDWOOD, Nicholas Paul Kenneth | Director | 43 Worley Road AL3 5NR St Albans Hertfordshire | British | 56429680001 | ||||||
| RICH, Michael William | Director designado | Hillfield Gorse Hill Farningham DA4 0JU Dartford Kent | British | 900020860001 | ||||||
| ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | 63986410004 | |||||
| WARNER, William | Director designado | 2 Honeysuckle Gardens CR0 8XU Croydon | British | 900019540001 | ||||||
| WEBB, Nigel Mark | Director | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | 58059360001 | |||||
| WESTON, Paul | Director | The Old Stables Lowsdon Lane Riseley MK44 1SN Bedfordshire | British | 73409670001 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0