WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04057457 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
- Recolección de residuos no peligrosos (38110) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación
¿Dónde se encuentra WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Dirección de la sede social | Indigo House Sussex Avenue LS10 2LF Leeds West Yorkshire |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
---|---|---|
WHITE ROSE ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED | 13 nov 2000 | 13 nov 2000 |
BROOMCO (2331) LIMITED | 22 ago 2000 | 22 ago 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Estado de capital el 23 ago 2021
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 13 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William J Seward como director el 15 oct 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr William Seward como director el 08 feb 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert John Guice como director el 08 feb 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Stericycle International Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Paul Johnston como director el 01 oct 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert John Guice como director el 01 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Daniel Ginnetti el 04 abr 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 ago 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GINNETTI, Daniel V | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United States | American | Chief Financial Officer | 193541820001 | ||||
DYSON, Gillian Marie | Secretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | 119888150001 | ||||||
LLOYD, David Alan | Secretario | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | British | Finance Director | 155636220001 | |||||
MIDDLETON, Stephen John | Secretario | Pannell House Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 120304280001 | |||||
SANDERS, Penelope Jane | Secretario | 2 Allerton Park LS7 4ND Leeds West Yorkshire | British | 88778740001 | ||||||
TAYLOR, Richard | Secretario | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Director | 106228180001 | |||||
TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria | Secretario | 853 Valley Road Glencoe Illinois 60022 Usa | American | Chief Financial Officer Cao | 98751560001 | |||||
DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016460001 | |||||||
ALUTTO, Charles Anthony | Director | Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Floor Kent United Kingdom | United Kingdom | American | Director | 134402900001 | ||||
BLYDE, William David | Director | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Director | 11292060003 | |||||
BRANDEL, Elizabeth | Director | N Sheridan Rd Lake Forest 1020 Illinois 60045 Usa | Usa | Usa | Finance | 115854300002 | ||||
CLESEN, John Fredrick | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Usa | American | Director | 156396820001 | ||||
COPLAND, David | Director | Floor, Apex House London Road Northfleet DA11 9PD Gravesend 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 137429730001 | ||||
CROSKERY, Colm Tomas | Director | Pkf Limited Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | Irish | Director | 101048750003 | |||||
FATCHETT, Brendan John | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 163463840001 | ||||
FOSS, Richard Lawrence | Director | Country Place Lake Forest 60045 882 Illinois Usa | Usa | American | Executive | 138699920001 | ||||
GRAVER, Neville Leslie Denis | Director | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | Irish | Finance Director | 121247930001 | |||||
GUICE, Robert John | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United Kingdom | British | Evp International | 203379250001 | ||||
HANCOCK, John Reginald | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 150864080001 | ||||
HEWITT, Terence John | Director | Pannel House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 68234450003 | |||||
HIGGINS, Andrew David | Director | Floor, Apex House London Road Northfleet DA11 9PD Gravesend 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 146636500001 | ||||
HINTON, Andrew Peter | Director | Flat 57 Centaur House Great George Street LS1 3LA Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 114646030001 | ||||
HUGHES, David | Director | 6 Queen Street LS1 2TW Leeds Pannell House West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | Director | 130254390001 | ||||
JOHNSTON, John Paul | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Ireland | Irish | Director | 162398480001 | ||||
KOGLER, Richard Thomas | Director | 6228 S. Richmond Willowbrook Illinois 60527 Usa | American | Chief Operating Officer | 98461760001 | |||||
LLOYD, David Alan | Director | Floor, Apex House London Road DA11 9PD Northfleet 2nd Kent United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 155636220001 | ||||
MIDDLETON, Stephen John | Director | Pannell House Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 120304280001 | |||||
MILLER, Mark Collier | Director | 15226 Rockland Road 60048 Libertyville Illinois 60048 Usa | Usa | American | Presindent & Ceo | 98272530001 | ||||
O'BRIEN, James Patrick | Director | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | Director | 106228260001 | |||||
SACRANIE, Shazeen Sattar | Director | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | American | 98272430003 | ||||||
SEWARD, William J, Mr. | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire | United States | American | Chief Commercial Officer | 256019320001 | ||||
SIMPSON, Paul | Director | Pannell House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Operations Director | 113998010002 | ||||
TEN BRINK, Fransiscus Johannes Maria | Director | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House West Yorkshire United Kingdom | Usa | American | Chief Financial Officer Cao | 98751560001 | ||||
WYATT, Nicholas Andrew | Director | Pannel House 6 Queen Street LS1 2TW Leeds West Yorkshire | British | Company Director | 73704370002 | |||||
DLA NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Fountain Precinct Balm Green S1 1RZ Sheffield | 900016450001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stericycle International Ltd | 06 abr 2016 | Sussex Avenue LS10 2LF Leeds Indigo House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene WHITE ROSE ENVIRONMENTAL LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Memorandum of deposit | Creado el 06 nov 2002 Entregado el 13 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Mortgage of assurance policies | Creado el 06 nov 2002 Entregado el 18 nov 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000461 nicholas andrew wyatt, wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000488 terence john hewitt, and wren life - syndicate 389 at lloyd's, policy number: 2000/0000000462 andrew peter hinton. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 21 dic 2000 Entregado el 22 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Memorandum of deposit | Creado el 21 dic 2000 Entregado el 22 dic 2000 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the credit facility | |
Breve descripción The "mortgaged securities" being all stock and share certificates and other marketable securities money or any account in the company's name in the bank's books or goods belonging to the company deposited with the bank or in the bank's hands. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0