BVP FINANCING LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBVP FINANCING LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04058739
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BVP FINANCING LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra BVP FINANCING LIMITED?

    Dirección de la sede social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BVP FINANCING LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BVP FINANCING LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cese del nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jean-Marc Vandevivere como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Christopher Michael John Forshaw como director el 06 dic 2012

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 06 dic 2012

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012

    3 páginasAA

    Nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 18 ago 2012 avec liste complète des actionnaires

    10 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital21 ago 2012

    Estado de capital el 21 ago 2012

    • Capital: GBP 20
    SH01

    Nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Jean-Marc Vandevivere como director el 13 jul 2012

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    17 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Graham Roberts como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de BVP FINANCING LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EKPO, Ndiana
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Secretario
    Chislehurst Road
    BR5 1NR Petts Wood
    182
    Kent
    United Kingdom
    Other138446320001
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    Langkawi
    2 Ashlea Road
    SL9 8NY Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British78691990001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secretario
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Secretario designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Director
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    Director
    Sandown Road
    KT10 9TT Esher
    27
    Surrey
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Director
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Director
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRILEY, Andrew
    11 Blackthorne Close
    B91 1PF Solihull
    West Midlands
    Director
    11 Blackthorne Close
    B91 1PF Solihull
    West Midlands
    BritishVice President118121250001
    CARTER, Simon Geoffrey
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Director
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CUTTS, John Charles
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    Director
    Tudor Gables Old Warwick Road
    Lapworth
    B94 6AY Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director56651680001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Director
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HODGE, Paul Antony
    89 Manor Road
    Dorridge
    B93 8TT Solihull
    West Midlands
    Director
    89 Manor Road
    Dorridge
    B93 8TT Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director61906560002
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Director
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    KEIR, David Christopher Lindsay
    Dale Farm
    Madewell
    NN6 9JE Northampton
    Northamptonshire
    Director
    Dale Farm
    Madewell
    NN6 9JE Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishVice President Of Development32255280002
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Director
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    RITBLAT, John, Sir
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    Director
    The Doric Villa 20 York Terrace East
    Regents Park
    NW1 4PT London
    EnglandBritishChairman And Managing Director41694870001
    RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    Director
    37 Queens Grove
    NW8 6HN London
    United KingdomBritishCompany Director35758050004
    ROBERTS, Graham Charles
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    Director
    6a Lower Belgrave Street
    SW1W 0LJ London
    EnglandBritishChartered Accountant79807180002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    Lorne House
    Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Sureveyor63986410004
    SMITH, Stephen Paul
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    SMITH, Stephen Paul
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Director
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishCompany Director148183670001
    VANDEVIVERE, Jean-Marc
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Director
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomFrenchCompany Director170947050001
    WATSON, Robert Joe
    Beukenhorstlaan 14
    Wassenaar
    2244 Gc
    Netherlands
    Director
    Beukenhorstlaan 14
    Wassenaar
    2244 Gc
    Netherlands
    AmericanPresident And Coo Of Prologis82650520001
    WEBB, Nigel Mark
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    Director
    Beech Lodge
    53 Crouch Hall Lane Redbourn
    AL3 7EU St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Surveyor58059360001
    WESTON SMITH, John Harry
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    Director
    10 Eldon Grove
    Hampstead
    NW3 5PT London
    EnglandBritishChartered Secretary13547380001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Director designado corporativo
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    ¿Tiene BVP FINANCING LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Jersey mortgage of shares
    Creado el 11 dic 2002
    Entregado el 19 dic 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The bank's right to retain possession of the certificates of title to the securities with all right,title,benefit,interest and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 dic 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Jersey mortgage of shares
    Creado el 28 jun 2002
    Entregado el 16 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The securities (as defined therein) together with all distributions dividends and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A jersey mortgage of shares
    Creado el 20 dic 2001
    Entregado el 04 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Pursuant to clause 2 of the agreement the company, as legal and beneficial owner agrees that the bank (or its nomonees, not being the company) shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities (together known as the "securities"), the shares, stocks, debenhtures stock, loan stock, bonds or units of a unit trust scheme, stock, debentures, debenture stock, loan, stock, bonds or units of a unit trust scheme specified in schedule 1 of the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Jersey mortgage of shares
    Creado el 12 abr 2001
    Entregado el 02 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and futire obligations monies and liabilities of the company to the chargee due under a facility agreement, the guarantee and/or the mortgage
    Breve descripción
    The company shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities being bvp (j) plot E1 limited,bvp (j) plot D2 limited and bvp (j) plot g limited and all shares stock debentures debenture stock bonds or units of a unit trust scheme please refer to form 395 for further details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Jersey mortgage of shares
    Creado el 12 abr 2001
    Entregado el 02 may 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and futire obligations monies and liabilities of the company to the chargee due under a facility agreement, the guarantee and/or the mortgage
    Breve descripción
    The company shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities being bvp (j) plot C1 limited and all shares stock debentures debenture stock bonds or units of a unit trust scheme please refer to form 395 for further details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 may 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 12 abr 2001
    Entregado el 27 abr 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 abr 2001Registro de un cargo (395)
    • 29 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0