BVP FINANCING LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | BVP FINANCING LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04058739 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de BVP FINANCING LIMITED?
- Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
¿Dónde se encuentra BVP FINANCING LIMITED?
Dirección de la sede social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de BVP FINANCING LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para BVP FINANCING LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jean-Marc Vandevivere como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Sarah Morrell Barzycki como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Lucinda Margaret Bell como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Mark Webb como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Michael John Forshaw como director el 06 dic 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Timothy Andrew Roberts como director el 06 dic 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 ago 2012 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Stephen Paul Smith como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Benjamin Toby Grose como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Simon Geoffrey Carter como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Jean-Marc Vandevivere como director el 13 jul 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 ago 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Roberts como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de BVP FINANCING LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKPO, Ndiana | Secretario | Chislehurst Road BR5 1NR Petts Wood 182 Kent United Kingdom | Other | 138446320001 | ||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Secretario | Langkawi 2 Ashlea Road SL9 8NY Chalfont St Peter Buckinghamshire | British | 78691990001 | ||||||
SCUDAMORE, Rebecca Jane | Secretario | 40 Canbury Avenue KT2 6JP Kingston Upon Thames Surrey | Other | 72249480003 | ||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
ADAM, Shenol | Director | 13 Beech Drive N2 9NX London | British | Company Director | 2068480001 | |||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Director | Sandown Road KT10 9TT Esher 27 Surrey | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||
BELL, Lucinda Margaret | Director | 6 Priory Gardens Chiswick W4 1TT London | England | British | Chartered Accountant | 32809050004 | ||||
BOWDEN, Robert Edward | Director | The Chase Ongar Road CM15 0DG Kelvedon Hatch Essex | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 152497530001 | ||||
BRILEY, Andrew | Director | 11 Blackthorne Close B91 1PF Solihull West Midlands | British | Vice President | 118121250001 | |||||
CARTER, Simon Geoffrey | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||
CLARKE, Peter Courtenay | Director | Oakmeade Park Road SL2 4PG Stoke Poges Berkshire | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 78691990003 | ||||
CUTTS, John Charles | Director | Tudor Gables Old Warwick Road Lapworth B94 6AY Solihull West Midlands | United Kingdom | British | Company Director | 56651680001 | ||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||
GROSE, Benjamin Toby | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||
HESTER, Stephen Alan Michael | Director | 3 Ilchester Place W14 8AA London | British | Chief Executive | 51688320001 | |||||
HODGE, Paul Antony | Director | 89 Manor Road Dorridge B93 8TT Solihull West Midlands | British | Company Director | 61906560002 | |||||
JONES, Andrew Marc | Director | Hazlewell Road Putney SW15 6LH London 2 | England | British | Company Director | 82020730004 | ||||
KEIR, David Christopher Lindsay | Director | Dale Farm Madewell NN6 9JE Northampton Northamptonshire | England | British | Vice President Of Development | 32255280002 | ||||
METLISS, Cyril | Director | 25 Foscote Road Hendon NW4 3SE London | British | Chartered Accountant | 3079600001 | |||||
RITBLAT, John, Sir | Director | The Doric Villa 20 York Terrace East Regents Park NW1 4PT London | England | British | Chairman And Managing Director | 41694870001 | ||||
RITBLAT, Nicholas Simon Jonathan | Director | 37 Queens Grove NW8 6HN London | United Kingdom | British | Company Director | 35758050004 | ||||
ROBERTS, Graham Charles | Director | 6a Lower Belgrave Street SW1W 0LJ London | England | British | Chartered Accountant | 79807180002 | ||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Director | Lorne House Oxshott Way KT11 2RU Cobham Surrey | England | British | Chartered Sureveyor | 63986410004 | ||||
SMITH, Stephen Paul | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||
SMITH, Stephen Paul | Director | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London | England | British | Company Director | 148183670001 | ||||
VANDEVIVERE, Jean-Marc | Director | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | French | Company Director | 170947050001 | ||||
WATSON, Robert Joe | Director | Beukenhorstlaan 14 Wassenaar 2244 Gc Netherlands | American | President And Coo Of Prologis | 82650520001 | |||||
WEBB, Nigel Mark | Director | Beech Lodge 53 Crouch Hall Lane Redbourn AL3 7EU St Albans Hertfordshire | England | British | Chartered Surveyor | 58059360001 | ||||
WESTON SMITH, John Harry | Director | 10 Eldon Grove Hampstead NW3 5PT London | England | British | Chartered Secretary | 13547380001 | ||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Director designado corporativo | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
¿Tiene BVP FINANCING LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
Jersey mortgage of shares | Creado el 11 dic 2002 Entregado el 19 dic 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The bank's right to retain possession of the certificates of title to the securities with all right,title,benefit,interest and dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Jersey mortgage of shares | Creado el 28 jun 2002 Entregado el 16 jul 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción The securities (as defined therein) together with all distributions dividends and interest. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A jersey mortgage of shares | Creado el 20 dic 2001 Entregado el 04 ene 2002 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descripción Pursuant to clause 2 of the agreement the company, as legal and beneficial owner agrees that the bank (or its nomonees, not being the company) shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities (together known as the "securities"), the shares, stocks, debenhtures stock, loan stock, bonds or units of a unit trust scheme, stock, debentures, debenture stock, loan, stock, bonds or units of a unit trust scheme specified in schedule 1 of the agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Jersey mortgage of shares | Creado el 12 abr 2001 Entregado el 02 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and futire obligations monies and liabilities of the company to the chargee due under a facility agreement, the guarantee and/or the mortgage | |
Breve descripción The company shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities being bvp (j) plot E1 limited,bvp (j) plot D2 limited and bvp (j) plot g limited and all shares stock debentures debenture stock bonds or units of a unit trust scheme please refer to form 395 for further details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Jersey mortgage of shares | Creado el 12 abr 2001 Entregado el 02 may 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All present and futire obligations monies and liabilities of the company to the chargee due under a facility agreement, the guarantee and/or the mortgage | |
Breve descripción The company shall have and retain possession of the certificates of title to the following securities being bvp (j) plot C1 limited and all shares stock debentures debenture stock bonds or units of a unit trust scheme please refer to form 395 for further details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 12 abr 2001 Entregado el 27 abr 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descripción .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0