SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED

SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04063031
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    • (6523) /
    • (9305) /

    ¿Dónde se encuentra SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    PINCO 1504 LIMITED31 ago 200031 ago 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital08 sept 2011

    Estado de capital el 08 sept 2011

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Ian Story como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Martin Keith Tyler como director

    3 páginasAP01

    Nombramiento de Jeremy Peter Small como secretario

    4 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Lisa Mcdonell como secretario

    1 páginasTM02

    Cambio de datos del director Mr Ian Graham Story el 06 oct 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr Ian Graham Story el 06 oct 2010

    3 páginasCH01

    Cambio de datos del director Matthew Gibson el 06 oct 2010

    3 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 31 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    14 páginasAR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    7 páginasAA

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    8 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    8 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 abr 2007

    13 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas225

    ¿Quiénes son los directivos de SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Secretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    British158291780001
    GIBSON, Matthew
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant82427280001
    TYLER, Martin Keith
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Great BritainBritishChartered Accountant158372390001
    MCDONELL, Lisa Michelle
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    Secretario
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    BritishSolicitor88620750001
    SHAY, Ian Lawton
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    Secretario
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director9138100003
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Secretario corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    COOK, Geoffrey Graham
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    Director
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    BritishCompany Director51386970005
    EDDINGTON, David
    22 Whitelee Crescent
    Newton Mearns
    G77 6UH Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    22 Whitelee Crescent
    Newton Mearns
    G77 6UH Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector63907560001
    FRASER, Angus Mackay
    Dunskey
    66 Newton Grove Newton Mearns
    G77 5QJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Dunskey
    66 Newton Grove Newton Mearns
    G77 5QJ Glasgow
    Lanarkshire
    BritishInsurance Broker94391140001
    GREENWAY, John Robert
    11 Oak Tree Close
    Strensall
    YO3 5TE York
    North Yorkshire
    Director
    11 Oak Tree Close
    Strensall
    YO3 5TE York
    North Yorkshire
    BritishMember Of Parliment57032610001
    HARRIS, Edward
    18 Beech Crescent
    G77 5BN Newton Mearns
    Glasgow
    Director
    18 Beech Crescent
    G77 5BN Newton Mearns
    Glasgow
    BritishCompany Director81098320001
    MEEHAN, Paul Christopher
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    Director
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director127255230002
    OWEN, David Edward
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    Director
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director2400660001
    POPPLEWELL, Kenneth
    3 Adel Towers Court
    Adel
    LS16 8ER Leeds
    West Yorkshire
    Director
    3 Adel Towers Court
    Adel
    LS16 8ER Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director43094790001
    PRENTICE, Douglas
    18 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    Director
    18 Pinewood Walk
    ML10 6UL Strathaven
    Lanarkshire
    BritishDirector63907770001
    PRESTON, Colin Taylor
    Avalon 4 Denholm Gardens
    Quarter
    ML3 7XY Hamilton
    Lanarkshire
    Director
    Avalon 4 Denholm Gardens
    Quarter
    ML3 7XY Hamilton
    Lanarkshire
    BritishCompany Director467360002
    SHAY, Ian Lawton
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director9138100003
    STORY, Ian Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Director
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant75238840004
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Director corporativo
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001

    ¿Tiene SMART & COOK (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 08 mar 2004
    Entregado el 24 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 24 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 08 mar 2004
    Entregado el 19 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Geoffrey Graham Cook
    Transacciones
    • 19 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 22 ene 2001
    Entregado el 31 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 03 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0