SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

SERVICED OFFICES UK GP LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSERVICED OFFICES UK GP LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04063878
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Dirección de la sede social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CORPORATE CENTRES GP LIMITED15 mar 200115 mar 2001
    STONEMARTIN (GP) LIMITED29 ago 200029 ago 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 jun 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginasLIQ13

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de St Helen's 1 Undershaft London EC3P 3DQ United Kingdom a 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS el 27 dic 2019

    1 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    4 páginasLIQ01

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 10 dic 2019

    LRESSP

    Cese del nombramiento de Kirsty Ann-Marie Wilman como director el 02 dic 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Karina Jane Bye como director el 02 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Nicholas Tebbutt como director el 02 dic 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David Rowley Rose como director el 02 dic 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Julian Miles Cobourne como director el 02 dic 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Jennifer Anne Lisbey como director el 02 dic 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Jennifer Anne Lisbey como director el 15 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Matthew James Torode como director el 23 ago 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 01 oct 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2018

    2 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2018 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Matthew Torode como director el 13 mar 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de David Leonard Grose como director el 13 mar 2018

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2017

    2 páginasAA

    Cambio de datos del director Mr Nicholas Tebbutt el 19 mar 2018

    2 páginasCH01

    Declaración de confirmación presentada el 18 sept 2017 con actualizaciones

    6 páginasCS01

    Nombramiento de Mr. Nicholas Tebbutt como director el 28 jul 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Catherine Jane Mccall como director el 28 jul 2017

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónSociedad limitada del Reino Unido
    Número de registro2084205
    1278390004
    BYE, Karina Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Director
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish239237640001
    ROSE, David Rowley
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Director
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish89567200001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Secretario
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    British62939740001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ASHCROFT, Jonathan Edwin
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Director
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish131434980001
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Director
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    BURGESS, Quentin James Neilson
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Director
    The Red House Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish42896080002
    CLARK, Philip John
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    Director
    26 Bourne Avenue
    Southgate
    N14 6PD London
    United KingdomBritish101932350001
    COBOURNE, Julian Miles
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Director
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    EnglandBritish198725060001
    DAWSON, Robert George Maxwell
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    Director
    Worrin Road
    Shenfield
    CM15 8DH Brentwood
    64
    Essex
    EnglandBritish77316930001
    DRYSDALE, James Ferguson
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    Director
    Flat 5
    2 Fair Street
    SE1 2XT London
    British61174240003
    ELLIS, Philip Frederick
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    Director
    Piglet Manner
    Bramerton Road, Burlingham
    NR14 7DE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish75296640001
    GOTTLIEB, Julius
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    Director
    8 Southway
    Totteridge
    N20 8EA London
    EnglandBritish32807790002
    GROSE, David Leonard
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    Director
    c/o Hermes
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    United Kingdom
    United KingdomAustralian120479020001
    JONES, Richard Peter
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    Director
    Tudor House
    11 Lower Street
    CM24 8LN Stansted
    EnglandBritish76584200002
    LAXTON, Chris James Wentworth
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Director
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish198871760001
    LAXTON, Christopher James Wentworth, Mr
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    Director
    High House Ranworth Road
    Hemblington
    NR13 4PJ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish62939740001
    LINDSEY, Joel Mark Woodliffe
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Director
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomNew Zealand140768720001
    LINEHAM, Timothy Mark Vaughan
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    Director
    Eastgate House
    Park Lane
    TN15 0JD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish66505360002
    LISBEY, Jennifer Anne
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    Director
    150 Cheapside
    EC2V 6ET London
    Hermes Investment Management
    United Kingdom
    United KingdomBritish259968930001
    MANSLEY, Nicholas John Fermor
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    Director
    4 Willis Road
    CB1 2AQ Cambridge
    EnglandBritish73817060002
    MCCALL, Catherine Jane
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    Director
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helen's
    United Kingdom
    United KingdomBritish204318160001
    MCKEOWN, Audrey
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Director
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomIrish124787300002
    SHAH, Nikunj Nalin
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    Director
    Norval Road
    HA0 3TE Wembley
    16
    Middlesex
    Uk
    United KingdomBritish131325870001
    TEBBUTT, Nicholas, Mr.
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    Director
    1 Undershaft
    EC3P 3DQ London
    St Helens
    United Kingdom
    United KingdomBritish228645590002
    THODAY, Corin Leonard
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    Director
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No 1
    Uk
    United KingdomBritish138095630001
    TORODE, Matthew James
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    Director
    Cheapside
    EC2U 6ET London
    150
    United Kingdom
    United KingdomBritish196412900002
    TURNER, Alex James
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    Director
    Priory Way
    SG4 9BH Hitchin
    12
    Hertfordshire
    United KingdomBritish110252440002
    WILMAN, Kirsty Ann-Marie
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    Director
    c/o Hermes Fund Managers Limited
    1 Portsoken Street
    E1 8HZ London
    Lloyds Chambers
    England
    EnglandBritish155163600002
    WISE, David Andrew John
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    Director
    20 Parkway
    Southgate
    N14 6QU London
    United KingdomBritish74016310001
    WOMACK, Ian Bryan
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    Director
    116 Union Street
    NR1 2TG Norwich
    United KingdomBritish33902000002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Director designado corporativo
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SERVICED OFFICES UK GP LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Norwich Union (Shareholder Gp) Limited
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    06 abr 2016
    Poultry
    EC2R 8EJ London
    No. 1
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registro03783750
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 25% pero no más del 50% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene SERVICED OFFICES UK GP LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Legal charge
    Creado el 08 dic 2008
    Entregado el 16 dic 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company as general partner on behalf of the partnership and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    L/H property k/a temple circus temple way bristol t/no. BL97044 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 16 dic 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2008
    Entregado el 22 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a peter house st peter's square manchester t/no GM597635 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2008
    Entregado el 22 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a 1 victoria square birmingham t/no WM172095 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2008
    Entregado el 22 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a 45-48 (inclusive) swallow street birmingham T.no WM367351 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Sscotland PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2008
    Entregado el 22 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The property k/a land on the south side of swallow street birmingham t/no WM368514 fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 21 jul 2008
    Entregado el 22 jul 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The propert k/a the golden eagle corner of hill street and swallow street birmingham t/no WM389526.
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 jul 2008Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 11 jun 2004
    Entregado el 19 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    The l/h property known as forbury square reading. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 jun 2004Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture containing fixed and floating charges
    Creado el 25 ene 2002
    Entregado el 29 ene 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    All undertaking property and assets of the partnership whatsoever and wheresoever. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 ene 2002Registro de un cargo (395)
    • 05 jul 2014Satisfacción de una carga (MR04)

    ¿Tiene SERVICED OFFICES UK GP LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 dic 2019Inicio de la liquidación
    18 feb 2021Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Profesional
    Grant Thornton Uk Llp 1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0