FIFTHGRANGE LIMITED
Visi ón general
Nombre de la empresa | FIFTHGRANGE LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | 04071712 |
Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | No |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FIFTHGRANGE LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra FIFTHGRANGE LIMITED?
Dirección de la sede social | Witan Gate House 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes United Kingdom |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FIFTHGRANGE LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 27 dic 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIFTHGRANGE LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Damian Garry Mcgloughlin el 12 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew Charles Coleman el 12 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simone Tudor como secretario el 31 ago 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2022 con actualizaciones | 7 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Homebase (Uk&I) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 dic 2021 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Homebase Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 dic 2021 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cambio de datos del director Andrew Charles Coleman el 15 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Damian Garry Mcgloughlin el 15 dic 2021 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Estado de capital el 14 dic 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 27 dic 2020 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 dic 2019 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2020 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 21 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2018 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Exercice comptable précédent raccourci du 30 jun 2019 au 30 dic 2018 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2018 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Ms Simone Tudor como secretario el 03 ene 2019 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 28 páginas | MA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FIFTHGRANGE LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G SECRETARIAL LIMITED | Secretario corporativo | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate England |
| 90084920001 | ||||||||||
COLEMAN, Andrew Charles | Director | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | England | British | Director | 252067350001 | ||||||||
MCGLOUGHLIN, Damian Garry | Director | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 242086250008 | ||||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Secretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 190890130001 | |||||||||||
MCKELVEY, Penelope Ann | Secretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | 179886780001 | |||||||||||
PARKER, Philip Alexander | Secretario | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | British | Company Secretary | 202472990003 | |||||||||
SHENTON, Paul Henry | Secretario | 25 Gilmais Bookham KT23 4RP Leatherhead Surrey | British | 64486620001 | ||||||||||
TUDOR, Simone | Secretario | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | 255103480001 | |||||||||||
WILLIS, Michael Haydn Allen | Secretario | 32 Old Oak Drive NN12 8DN Silverstone Northamptonshire | British | 2684970005 | ||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secretario designado corporativo | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
ADAMS, David William | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | Finance Director | 153463840001 | ||||||||
BENTLEY, Gordon Andrew | Director | 7 Hollybush Lane AL5 4AL Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 43125610002 | ||||||||
BOYS, Rodney John | Director | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Chief Financial Officer | 204065540002 | ||||||||
DAVIS, Donald Fuller | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | American | Company Director | 153470640001 | ||||||||
DAVIS, Peter-John Charles | Director | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Chief Operating Officer | 240193510002 | ||||||||
FULLER, Neil Frank | Director | Rye House Icknield Way HP23 4JU Tring Hertfordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 71239990003 | ||||||||
GRESHAM, Nicholas John | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Finance Director | 91773790001 | ||||||||
HAMILTON, Deborah Pamela | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Company Secretary | 116752570006 | ||||||||
HAYDON, David James | Director | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | United Kingdom | Australian | Retail Director | 329593090001 | ||||||||
HOLMES, Colin John | Director | The Stone House Welford Road NN6 8SJ Thornby Northamptonshire | British | Company Secretary | 30687300002 | |||||||||
LAYTON, Matthew Robert | Director designado | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||||||
LOVERING, John David | Director | 75 Capital Wharf High Street Wapping E1W 1LY London | British | Company Director | 73573160001 | |||||||||
PARKER, Philip Alexander | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | United Kingdom | British | Company Secretary | 202472990003 | ||||||||
POTTER, Cheryl | Director | 175 Hillcrest KT13 8AS Weybridge Surrey | British | Venture Capitalist | 75177990001 | |||||||||
RICHARDS, Martin Edgar | Director designado | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||||||
SELLARS, Ian | Director | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | United Kingdom | British | Company Director | 107731430001 | ||||||||
SHENTON, Paul Henry | Director | Avebury 489-499 Avebury Boulevard MK9 2NW Milton Keynes | England | British | Accountant | 64486620001 | ||||||||
SHERWOOD, Charles Nigel Cross | Director | Cavewood Rectory Lane SG3 6RD Datchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | Venture Capitalist | 142567110001 | ||||||||
TEMPLEMAN, Robert William | Director | Greenlands Bellwood Court ME3 8RT St. Mary Hoo Kent | British | Director | 75683610001 | |||||||||
WOODHOUSE, Christopher Kevin | Director | 25 Chester Row SW1W 9JF London | British | Director | 48827150004 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FIFTHGRANGE LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homebase (Uk&I) Holdings Limited | 15 dic 2021 | 3rd Floor 11-12 St James's Square SW1Y 4LB London Suite 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Homebase Group Limited | 01 ago 2016 | 500-600 Witan Gate MK9 1BA Milton Keynes Witan Gate House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene FIFTHGRANGE LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 09 nov 2018 Entregado el 15 nov 2018 | Pendiente | ||
Breve descripción See clause 3.1 of the debenture, which creates a fixed charge over any right, title or interest which the company has now or may subsequently acquire to or in any land (as defined in the debenture). See clause 3.9 of the debenture, which creates a fixed charge over all intellectual property rights (as defined in the debenture) (including all fees, royalties and other rights of every kind relating to or deriving from such rights) such as:. Country mark status app no. App date reg no.. United kingdom. Apotments registered 2544622 14-apr-2010 2544622. united kingdom. Compot registered 2312248 03-oct-2002 2312248. hong kong duracoat registered 300974160 16-oct-2007 300974160. please also see schedule 6 (specified intellectual property) within the debenture for further details (this schedule includes further charged intellectual property rights). La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
A registered charge | Creado el 01 nov 2018 Entregado el 06 nov 2018 | Pendiente | ||
Breve descripción Not applicable. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Debenture | Creado el 02 mar 2001 Entregado el 21 mar 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All indebtedness and other liabilities due or to become due from the company to all or any of the finance parties (as defined) and/or any receiver (as defined) under all or any of the finance documents (as defined) | |
Breve descripción Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0