TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED

TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTGHL REALISATIONS 2011 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04079450
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    • (5510) /

    ¿Dónde se encuentra TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    KPMG LLP
    Arlington Business Park Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE GLASSHOUSE HOTEL LIMITED13 nov 200013 nov 2000
    DMWSL 322 LIMITED27 sept 200027 sept 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de acreedores

    21 páginasLIQ14

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2017

    21 páginasLIQ03

    Presentación de insolvencia

    Insolvency:secretary of state's release of liquidator
    1 páginasLIQ MISC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2016

    21 páginas4.68

    Orden judicial de insolvencia

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    30 páginasLIQ MISC OC

    Renuncia de un liquidador

    1 páginas4.33

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    2 páginas600

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2015

    15 páginas4.68

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Orden judicial de insolvencia

    Court order INSOLVENCY:court order - replacement of liquidator
    9 páginasLIQ MISC OC

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2014

    18 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2013

    33 páginas4.68

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 27 nov 2012

    41 páginas4.68

    Aviso de cambio de la administración a la liquidación voluntaria de acreedores

    1 páginas2.34B

    Informe de progreso del administrador hasta 11 nov 2011

    75 páginas2.24B

    Informe de progreso del administrador hasta 28 oct 2011

    75 páginas2.24B

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Aviso de extensión del período de la administración

    1 páginas2.31B

    Informe de progreso del administrador hasta 28 abr 2011

    47 páginas2.24B

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed the glasshouse hotel LIMITED\certificate issued on 01/06/11
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name01 jun 2011

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 11 may 2011

    RES15

    Aviso de cambio de nombre

    2 páginasCONNOT

    Informe de progreso del administrador hasta 16 dic 2010

    111 páginas2.24B

    ¿Quiénes son los directivos de TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CRANWELL, Timiko
    Wigmore Street
    W1U 2SJ London
    78-80
    Secretario
    Wigmore Street
    W1U 2SJ London
    78-80
    AustralianLawyer112931590018
    AL JABER, Bashayer Mohammed E
    10th Floor Al-Mahmal Tower
    Al Balad
    21474 Jeddah
    PO BOX 16645
    Saudi Arabia
    Director
    10th Floor Al-Mahmal Tower
    Al Balad
    21474 Jeddah
    PO BOX 16645
    Saudi Arabia
    Saudi ArabiaSaudi ArabianDirector128877120001
    AL JABER, Mashael Mohammed Bin Issa
    10th Floor, Ai Mahmal Tower,
    King Abdulaziz Street
    FOREIGN Jeddah
    21474
    Saudi Arabia
    Director
    10th Floor, Ai Mahmal Tower,
    King Abdulaziz Street
    FOREIGN Jeddah
    21474
    Saudi Arabia
    Saudi ArabiaSaudi ArabianCompany Director123961260001
    AL JABER, Mohamed Bin Issa
    10th Floor, Ai Mahmal Tower,
    King Abdulaziz Street
    FOREIGN Jeddah
    21474
    Saudi Arabia
    Director
    10th Floor, Ai Mahmal Tower,
    King Abdulaziz Street
    FOREIGN Jeddah
    21474
    Saudi Arabia
    Saudi ArabiaSaudi ArabianCompany Director123961930001
    BROOK, Richard James Harry
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    Secretario
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director43867900001
    ENGLAND, Karen Margaret
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    Secretario
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    BritishAccountant92797270001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Secretario
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishAccountant24300100007
    DM COMPANY SERVICES LIMITED
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    Secretario designado corporativo
    16 Charlotte Square
    EH2 4DF Edinburgh
    Midlothian
    900000320001
    BROOK, Richard James Harry
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    Director
    Hostye Lodge Cudham Lane North
    Cudham
    TN14 7QP Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishCompany Director43867900001
    ENGLAND, Karen Margaret
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    Director
    The Morocco Store
    Flat 3 1 Leathermarket Street
    SE1 3HN London
    BritishAccountant92797270001
    PRATT, Kenneth Leslie Thomas
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    Director
    Manor Farm Kirk Hill
    East Bridgford
    NG13 8PE Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant24300100007
    TYRIE, Peter Robert
    33 Seaton Close
    Putney Heath
    SW15 3TJ London
    Director
    33 Seaton Close
    Putney Heath
    SW15 3TJ London
    United KingdomBritishHotelier152110270001
    25 NOMINEES LIMITED
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    Director corporativo
    Royal London House
    22-25 Finsbury Square
    EC2A 1DX London
    42409900001

    ¿Tiene TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Second ranking debenture
    Creado el 22 jun 2010
    Entregado el 06 jul 2010
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transacciones
    • 06 jul 2010Registro de un cargo (MG01)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 22 august 2007 and
    Creado el 10 ago 2007
    Entregado el 06 sept 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Hotel unit omni greenside place edinburgh lying in the county of midlothian t/no MID56857.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Security Trustee)
    Transacciones
    • 06 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 10 ago 2007
    Entregado el 21 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from eton group holdings limited or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (Security Trustee)
    Transacciones
    • 21 ago 2007Registro de un cargo (395)
    • 01 jul 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Standard security presented for registration in scotland on 16 december 2005 and
    Creado el 14 dic 2005
    Entregado el 30 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from eton group limited to the banks and the overdraft bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The interest under a lease of the subjects known as hotel unit omni greenside place edinburgh t/n MID56857.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) P.L.C. as Security Trustee for the Banks and the Overdraft Bank
    Transacciones
    • 30 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creado el 14 dic 2005
    Entregado el 17 dic 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Aib Group (UK) PLC (as Security Trustee for the Banks)
    Transacciones
    • 17 dic 2005Registro de un cargo (395)
    • 17 ago 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 19/02/04 and
    Creado el 22 ene 2004
    Entregado el 06 mar 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Lease dated 26 & 27 november 2003 and granted by pillar projects limited in favour of the glasshouse hotel limited and eton group limited (as guarantor) of subjects forming hotel unit omni greensde place edinburgh lying in the county of midlothian.
    Personas con derecho
    • Te Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Banks
    Transacciones
    • 06 mar 2004Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 08 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    Debenture
    Creado el 07 ago 2001
    Entregado el 11 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the banks on any account whatsoever (all terms as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Banks)
    Transacciones
    • 11 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 07 ene 2006Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (403b)
    • 08 ene 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene TGHL REALISATIONS 2011 LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 nov 2011Fin de la administración
    17 jun 2010Inicio de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Profesional
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    FechaTipo
    28 nov 2011Inicio de la liquidación
    30 abr 2019Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de acreedores
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Jane Bronwen Moriarty
    Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    RG7 4SD Theale
    Reading
    Profesional
    Kpmg Llp
    Arlington Business Park
    RG7 4SD Theale
    Reading
    Allan Watson Graham
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Profesional
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Neil David Gostelow
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Profesional
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Profesional
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0