CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED

CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04090240
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MWB CANNON CENTRE LEASE NO.2 LIMITED26 ene 200126 ene 2001
    IBIS (625) LIMITED13 oct 200013 oct 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 13 oct 2017 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Nombramiento de Ms Lucy Baird como director el 19 jun 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christine Anne Mattimore como director el 19 jun 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Christine Anne Mattimore como director el 27 abr 2017

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Sanne Secretaries Limited como secretario el 27 abr 2017

    2 páginasAP04

    Nombramiento de Mr Anton Seatter como director el 27 abr 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian James Palmer Brown como director el 27 abr 2017

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ross Blair como director el 27 abr 2017

    1 páginasTM01

    Domicilio social registrado cambiado de 100 New Bridge Street London EC4V 6JA a 21 Palmer Street London SW1H 0AD el 15 may 2017

    1 páginasAD01

    Cancelación total de la carga 3

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 040902400010

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 6

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 040902400009

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 5

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    5 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2016

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de Michael James Topham como director el 31 dic 2016

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    9 páginasAA

    Nombramiento de Ross Blair como director el 19 dic 2016

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Michael James Topham el 05 dic 2016

    2 páginasCH01

    ¿Quiénes son los directivos de CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SANNE SECRETARIES LIMITED
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Secretario corporativo
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Forma jurídicaPRIVATE LIMITED COMPANY
    Tipo de identificaciónNo EEE
    Autoridad legalCOMPANIES (JERSEY) LAW 1991
    231525890001
    BAIRD, Lucy
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    Director
    Castle Street
    JE4 5UT St Helier
    13
    Jersey
    Channel Islands
    JerseyBritish214316900001
    SEATTER, Anton
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Director
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    EnglandBritish231518160001
    REYNOLDS, Andrew John
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    Secretario
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    British70863380005
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Secretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Secretario corporativo
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secretario corporativo
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    BALFOUR-LYNN, Richard Gary
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    Director
    Connaught Square
    W2 2HG London
    6
    United KingdomBritish34251500001
    BIBRING, Michael Albert
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    Conifers
    Hive Road
    WD23 1JG Bushey Heath
    Hertfordshire
    EnglandBritish9320160002
    BLAIR, Ross
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Director
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish154858730001
    BLURTON, Andrew Francis
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    Director
    Old Cedar House
    Guildford Road
    GU6 8LT Cranleigh
    Surrey
    EnglandBritish53724380001
    BROWN, Ian James Palmer
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Director
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritish127801560001
    CONNOLLEY, Dominic
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    Director
    151 Gladstone Road
    Wimbledon
    SW19 1QS London
    British119088700001
    HARRISON, John William
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    Director
    97 Clifton Hill
    NW8 0JR London
    United KingdomBritish69263980002
    JONES, Neil
    29 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    Director
    29 Langland Gardens
    NW3 6QE London
    American58464510001
    LEWIS, Philip Geoffrey
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    Director
    1 Parkside
    NW7 2LJ London
    EnglandBritish6639590001
    MATTIMORE, Christine Anne
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Director
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    United KingdomAmerican207880160001
    MUSGRAVE, Stephen Howard Rhodes
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    Director
    4 Haverfield Gardens
    Kew
    TW9 3DD Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish6981200001
    REYNOLDS, Andrew John
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    Director
    The Portobello Arms
    Chartridge Lane Chartridge
    HP5 2TF Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish70863380005
    RIDDELL, James Hendry
    17 Clearwater House
    Langley Waterside
    BR3 3GD Beckenham
    Kent
    Director
    17 Clearwater House
    Langley Waterside
    BR3 3GD Beckenham
    Kent
    EnglandBritish119000220001
    SHASHOU, Joseph Saleem
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    Director
    28 Elm Tree Road
    NW8 9JT London
    United KingdomBrazilian51723030002
    SINGH, Jagtar
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    Director
    6 Paines Lane
    HA5 3DQ Pinner
    Middlesex
    United KingdomBritish121710890001
    TOPHAM, Michael James
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    Director
    Welbeck Street
    W1G 9YQ London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish153072620019
    WYPER, John Stuurman
    100 New Bridge Street
    London
    EC4V 6JA
    Director
    100 New Bridge Street
    London
    EC4V 6JA
    United KingdomUsa110361190007
    DECHERT NOMINEES LIMITED
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    Director corporativo
    2 Serjeants Inn
    EC4Y 1LT London
    73625410001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    78 Cannon Street Gp Limited
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    06 abr 2016
    New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    100
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaPrivate Limited Company
    País de registroEngland & Wales
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroCompanies House For England & Wales
    Número de registro4411068
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene CANNON STREET NOMINEES NO.2 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 13 sept 2013
    Entregado el 30 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag
    Transacciones
    • 30 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 13 sept 2013
    Entregado el 30 sept 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Land and buildings at 78 cannon street london. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag
    Transacciones
    • 30 sept 2013Registro de una carga (MR01)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Third party legal charge
    Creado el 11 jun 2009
    Entregado el 15 jun 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from 78 cannon street limited partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All the l/h land and premises situate and k/a main block bush lane block and podium block situated on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252045 and l/h land and premises situate at and k/a main block bush lane block and podium block situate on, over and under cannon street station cannon street london t/no. LN252857 and each and every part thereof including all rights powers easements and liberties attached inlcuding also all buildings erected including the development meaning the scheme of works to be carried out at the property of 400,000 sq ft of office accommodation over 8 storeys above mainline station na d approx 17,300 sq ft. Of retail accommodation see image for full details.
    Personas con derecho
    • Candar Finance S.A.R.L.
    Transacciones
    • 15 jun 2009Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Junior debenture
    Creado el 07 dic 2007
    Entregado el 20 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch (The Agent)
    Transacciones
    • 20 dic 2007Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mezzanine debenture
    Creado el 26 mar 2007
    Entregado el 30 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transacciones
    • 30 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 26 mar 2007
    Entregado el 30 mar 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag,London Branch
    Transacciones
    • 30 mar 2007Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 12 dic 2006
    Entregado el 22 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transacciones
    • 22 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Mezzanine debenture
    Creado el 12 dic 2006
    Entregado el 22 dic 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    78 cannon street london l/h t/no LN252045 fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transacciones
    • 22 dic 2006Registro de un cargo (395)
    • 28 abr 2017Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 11 jul 2002
    Entregado el 26 jul 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the 78 cannon street limited partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 jul 2002Registro de un cargo (395)
    • 18 sept 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture made between mwb cannon centre no.1 Limited, mwb cannon centre no.2 Limited, mwb cannon centre lease no.1 Limited, mwb cannon centre lease no. 2 limited (1) and the chargee (2) and 3 (the "debenture")
    Creado el 15 mar 2001
    Entregado el 20 mar 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All present and future obligations due or to become due from any borrower to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as defined under (and as defined in) the credit agreement dated 16TH may 2000) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) on any account whatsoever
    Breve descripción
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Eurohypo Aktiengesellschaft Europaische Hypothekenbank Der Deutschen Bank, London Branch
    Transacciones
    • 20 mar 2001Registro de un cargo (395)
    • 19 jul 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0