ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED

ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04095400
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Forge Lane
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    INGLEBY (1361) LIMITED24 oct 200024 oct 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Domicilio social registrado cambiado de Repton House Bretby Business Park, Ashby Road Burton upon Trent Staffordshire DE15 0YZ England a Forge Lane Killamarsh Sheffield S21 1BA el 20 sept 2023

    1 páginasAD01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2022

    1 páginasAA

    Cese del nombramiento de Simon David Martle como director el 01 ago 2023

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2022 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021

    1 páginasAA

    Registro de la carga 040954000016, creada el 31 ago 2022

    90 páginasMR01

    Registro de la carga 040954000015, creada el 20 jun 2022

    96 páginasMR01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del director Mrs Helen Barrett-Hague el 29 sept 2021

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Mrs Helen Barrett-Hague como director el 28 sept 2021

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Molyneux como secretario el 28 sept 2021

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mrs Helen Barrett-Hague como secretario el 28 sept 2021

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Ian Molyneux como director el 28 sept 2021

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Mr Simon David Martle el 09 sept 2021

    2 páginasCH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019

    1 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 24 oct 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cancelación total de la carga 040954000010

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Mr Simon David Martle como director el 01 sept 2020

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Michael Joseph Quinn como director el 13 mar 2020

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Lisa Marie Oxnard como director el 13 mar 2020

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Secretario
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    287748390001
    BARRETT-HAGUE, Helen
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Director
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    EnglandBritishSolicitor287804380001
    QUINN, Michael Joseph
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    Director
    Killamarsh
    S21 1BA Sheffield
    Forge Lane
    England
    IrelandIrishCeo268174890001
    BUNDRED, David George
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    Secretario
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director70291370001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Secretario
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    British34443700002
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Secretario
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    British164533210001
    TILLEY, Michael John
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    Secretario
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    BritishDirector60728390001
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Secretario designado corporativo
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    ASTON, Stephen Mark
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    Director
    The Gables
    Rowley Avenue
    ST17 9AA Stafford
    United KingdomBritishFinance Director287327450002
    BULL, George
    3 Murdoch Close
    Ferndale Manor
    NG22 8FE Farnsfield
    Nottinghamshire
    Director
    3 Murdoch Close
    Ferndale Manor
    NG22 8FE Farnsfield
    Nottinghamshire
    BritishChief Financial Officer47402550004
    BUNDRED, David George
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director70291370001
    DRURY, Phillip Michael
    47 Cranborne Avenue
    SG4 2BS Hitchin
    Herts
    Director
    47 Cranborne Avenue
    SG4 2BS Hitchin
    Herts
    United KingdomBritishDirector100342780001
    ELLIS, William Michael
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    Director
    Manor Drive
    Worthington
    LE65 1RN Ashby-De-La-Zouch
    The Manor House
    Leicestershire
    United KingdomAmericanChief Executive Officer134919220003
    HINKS, Duncan Andrew
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton-On-Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Financial Officer164530200005
    HOLLAND, William George
    1 Heathervale
    NG2 7ST West Bridgford
    Nottinghamshire
    Director
    1 Heathervale
    NG2 7ST West Bridgford
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector76633660001
    JACKSON, Howard Watson
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    Director
    Red House Farm
    CV35 0EB Little Kineton
    Warwickshire
    United KingdomBritishLawyer34443700002
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Director
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    LEWIS, Eric James
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    Director
    Rowan House
    32 Nursery Lane, Hopwas
    B78 3AS Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritishChief Executive75455450001
    MARTLE, Simon David
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Director
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandEnglishChief Financial Officer151541840002
    MOLYNEUX, Ian
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Director
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    United KingdomBritishSolicitor75284220004
    OXNARD, Lisa Marie
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    Director
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer253562580001
    SCHOFIELD, Alistair John
    136 Albert Palace Mansions
    SW11 4DJ Lurline Gardens
    London
    Director
    136 Albert Palace Mansions
    SW11 4DJ Lurline Gardens
    London
    BritishDirector76633570001
    SCHURCH, Michael John
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton On Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    Director
    Millennium Court
    First Avenue
    DE14 2WH Burton On Trent
    Doncasters Group Limited
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector42065200003
    SMITH, Peter John
    73 Upton End Road
    Shillington
    SG5 3PE Hitchin
    Hertfordshire
    Director
    73 Upton End Road
    Shillington
    SG5 3PE Hitchin
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director94974400001
    TILLEY, Michael John
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    Director
    Silver Birches 189 Main Street
    LE67 1AH Thornton
    Leicestershire
    BritishDirector60728390001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Director designado corporativo
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    06 abr 2016
    Bretby Business Park, Ashby Road
    DE15 0YZ Burton Upon Trent
    Repton House
    Staffordshire
    England
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroUnited Kingdom
    Autoridad legalCompanies Acts 1985 & 1989
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro04081354
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    24 oct 201628 feb 2017La empresa aún no ha completado las medidas razonables para determinar si existe alguna persona que sea una persona registrable o una entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene ROSS CATHERALL (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 31 ago 2022
    Entregado el 03 sept 2022
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 03 sept 2022Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 20 jun 2022
    Entregado el 05 jul 2022
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Americas Llc (As Security Agent)
    Transacciones
    • 05 jul 2022Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 06 mar 2020
    Entregado el 11 mar 2020
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Wells Fargo Capital Finance (UK) Limited
    Transacciones
    • 11 mar 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 06 mar 2020
    Entregado el 10 mar 2020
    Pendiente
    Breve descripción
    Not applicable.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Glas Americas Llc (As Security Agent)
    Transacciones
    • 10 mar 2020Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 27 sept 2017
    Entregado el 03 oct 2017
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of America, N.A.
    Transacciones
    • 03 oct 2017Registro de una carga (MR01)
    • 21 feb 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2013
    Entregado el 18 abr 2013
    Pendiente
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch as Security Agent
    Transacciones
    • 18 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2013
    Entregado el 18 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Credit Suisse Ag, Cayman Islands Branch as Security Agent
    Transacciones
    • 18 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    • 10 sept 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 09 abr 2013
    Entregado el 18 abr 2013
    Satisfecho en su totalidad
    Breve descripción
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Bank of America, N.A. as Security Agent
    Transacciones
    • 18 abr 2013Registro de una carga (MR01)
    • 21 feb 2020Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £50M pik facility agreement dated 3 april 2007 and
    Creado el 16 may 2007
    Entregado el 01 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 01 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £57.5M mezzanine facility agreement dated 3 april 2007 and
    Creado el 16 may 2007
    Entregado el 01 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 01 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Guarantee increase deed in relation to a £832.5M senior facilities agreement dated 3 april 2007 and
    Creado el 16 may 2007
    Entregado el 01 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 01 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 15 may 2007
    Entregado el 23 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transacciones
    • 23 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 abr 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 04 may 2006
    Entregado el 16 may 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transacciones
    • 16 may 2006Registro de un cargo (395)
    • 01 jun 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A supplemental composite guarantee and debenture between the company,doncasters limited ("doncasters") and the security agent (the "supplemental deed"). The supplemental deed is supplemental to a composite guarantee and debenture dated 20 august 2001 made between,amongst others,the company,doncasters and the security agent (the "debenture")
    Creado el 07 dic 2001
    Entregado el 18 dic 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies,obligations and liabilities due or to become due from the company to the security agent (as defined) and the other lenders (as defined) in each case pursuant to the common terms agreement,the senior facilities agreement,the mezzanine bridge facility agreement and the ancillary facilities letter (each as defined) and all other monies, obligations and liabilities due,owing and incurred under or pursuant to various other documents and agreements (all as defined)
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.,as Security Agent and Trustee for the Financeparties
    Transacciones
    • 18 dic 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 20 ago 2001
    Entregado el 29 ago 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred by the company to the finance parties or any of them, including, without limitation, all monies, obligations and liabilities due, owing and incurred under or pursuant to the finance documents (all terms as defined).
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The "Security Agent")
    Transacciones
    • 29 ago 2001Registro de un cargo (395)
    • 24 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)
    A composite guarantee and debenture
    Creado el 31 dic 2000
    Entregado el 09 ene 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All indebtedness, liabilities and obligations due or to become due in any manner whatsoever to the security beneficiaries (as defined in an intercreditor agreement dated 31 december 2000) by any group company (as defined in the intercreditor agreement) under the working capital facility (as defined in a facilities agreement dated 31 december 2000) and pursuant to the guarantee or otherwise
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transacciones
    • 09 ene 2001Registro de un cargo (395)
    • 09 ago 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0