FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaFIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa 04096014
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    West Point 501 Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED29 nov 200129 nov 2001
    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED25 oct 200025 oct 2000

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Vencido
    Próximas cuentas
    Próximo período contable finaliza el31 dic 2013
    Próximas cuentas vencen el30 sept 2014
    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Devolución de la reunión final en una liquidación voluntaria de miembros

    8 páginas4.71

    Declaración de recibos y pagos del liquidador hasta 03 sept 2015

    9 páginas4.68

    Domicilio social registrado cambiado de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ England a West Point 501 Chester Rd Old Trafford Manchester M16 9HU el 12 sept 2014

    1 páginasAD01

    Declaración de solvencia

    3 páginas4.70

    Nombramiento de un liquidador voluntario

    1 páginas600

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 04 sept 2014

    LRESSP

    Domicilio social registrado cambiado de * Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX* el 29 may 2014

    1 páginasAD01

    Déclaration annuelle établie au 23 oct 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital23 oct 2013

    Estado de capital el 23 oct 2013

    • Capital: GBP 1,358,129
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 dic 2012

    9 páginasAA

    Cese del nombramiento de John Flood como director

    1 páginasTM01

    Cancelación total de la carga 4

    4 páginasMR04

    Nombramiento de Sherard Secretariat Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Paul Birch como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Mr Andrew Latham Nelson como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Melvyn Ewell como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Fraser como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de David Arnold como director

    1 páginasTM01

    legacy

    3 páginasMG02

    legacy

    3 páginasMG02

    Déclaration annuelle établie au 23 oct 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Ian Ellis Fraser como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr David Llewelyn Arnold como director

    2 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    10 páginasAA

    Domicilio social registrado cambiado de * Gordon House Sceptre Way Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 6AW United Kingdom* el 31 oct 2011

    1 páginasAD01

    ¿Quiénes son los directivos de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secretario corporativo
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    Director
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    United KingdomBritish76116640002
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritish61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Director
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritish36191090003
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secretario
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secretario
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    British36153790001
    O'MALLEY, Ann Marie
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Secretario
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British38211680002
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Secretario
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secretario designado corporativo
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish181213200001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Director
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritish116126370001
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritish73695830003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUk28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Director
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritish36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Director
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritish61478920003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Director
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Director
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish51438040006
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Director
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Irish96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Director
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Director
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Director
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritish17129800004
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Director
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    British55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Director
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British25364820002
    THORNTON, James Stephen
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    Director
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    British67569070001

    ¿Tiene FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 18 may 2007
    Entregado el 31 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 may 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 jul 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 and
    Creado el 07 feb 2002
    Entregado el 09 feb 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    The f/h property being land and buildings on the north west side of queen street, farnworth, t/no GM86886.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficiaries
    Transacciones
    • 09 feb 2002Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Creado el 01 nov 2001
    Entregado el 02 nov 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transacciones
    • 02 nov 2001Registro de un cargo (395)
    • 14 mar 2013Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02)
    Debenture
    Creado el 18 may 2001
    Entregado el 07 jun 2001
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 18TH may 2001 and any other monies under the debenture
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Enterprise PLC
    Transacciones
    • 07 jun 2001Registro de un cargo (395)
    • 02 nov 2001Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (403a)

    ¿Tiene FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    04 sept 2014Inicio de la liquidación
    09 abr 2017Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Profesional
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0