CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE
Visión general
| Nombre de la empresa | CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social, exención del uso de 'Limited' |
| Número de empresa | 04099352 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
- Otras actividades de servicios n.c.p. (96090) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Dirección de la sede social | Fletcher House 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Shropshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| SHREWSBURY AND CENTRAL SHROPSHIRE CITIZENS ADVICE BUREAU | 31 oct 2000 | 31 oct 2000 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 03 dic 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 17 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 03 dic 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Angela Marie Williams como director el 18 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Minh Tuan Hoang como director el 18 nov 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher Deaves como director el 20 may 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2025 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Penelope Angela Cooper como director el 26 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2024 | 49 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elaine Sharon Williams como director el 11 oct 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 30 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 27 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Judith Helene Lancaster como director el 16 nov 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 mar 2023 | 42 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew John Brenan como director el 01 sept 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Elaine Sharon Williams como director el 25 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Brenan el 19 jul 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Philpott como director el 03 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Andrew John Brenan el 01 abr 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Judith Helene Lancaster como director el 23 may 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Julie Elizabeth Bertolini como director el 22 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 dic 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bethan Mair Haulwen Cross como director el 26 nov 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANGTON, Paul Frederick Thomas | Secretario | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | 193028070001 | |||||||
| BOOTE, Christopher Kenneth | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | United Kingdom | 83506880001 | |||||
| DEAVES, Christopher | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 174911500001 | |||||
| HARRISON, Joanne Elizabeth | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 257969730002 | |||||
| HINKLEY, Peter Antony | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 166467400001 | |||||
| HOANG, Minh Tuan | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | England | British | 197005450001 | |||||
| HOWITT, Andrew John | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | England | British | 193027920001 | |||||
| LANGTON, Paul Frederick Thomas | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire England | England | British | 85782560002 | |||||
| WILLIAMS, Angela Marie | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | England | British | 343032590001 | |||||
| BINNS, Linda Ann | Secretario | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | 188837720001 | |||||||
| HAINES, Katharine Elizabeth | Secretario | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | 156560310001 | |||||||
| LEWIS, Edmund | Secretario | Oacis 21 Oaks Road SY6 7AX Church Stretton Salop | British | 72630870001 | ||||||
| PETERS, Michael Harold Jonah, Commander | Secretario | Aylestone Weston Lane SY11 2BG Oswestry | British | 72630850002 | ||||||
| WARREN, Elizabeth Jane | Secretario | Oakland Mill Lane Hanwood SY5 8LT Shrewsbury Salop | British | 111346410001 | ||||||
| ADAMS, Elizabeth Mary | Director | Sutton Grove SY2 6DN Shrewsbury 1 Shropshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147490940001 | |||||
| ADAMS, Gareth James | Director | Hope Cottage Nant Y Caws SY10 9AN Oswestry Shropshire | United Kingdom | British | 105546540001 | |||||
| ADDERLEY, Robert Vernon | Director | 8 The Rocks Hereford Road SY3 7QU Shrewsbury Salop | United Kingdom | British | 113286420001 | |||||
| ALLCROFT, Allan | Director | 4 Middletown Square Monkmoor SY2 5TW Shrewsbury Shropshire | British | 75409780001 | ||||||
| ANDREWS, Elizabeth | Director | 49 Lydbury North SY7 8AR Craven Arms Shropshire | United Kingdom | British | 103654290002 | |||||
| BEARD, James Cameron | Director | Greystones Crickheath SY10 8DU Oswestry Shropshire | United Kingdom | British | 43788020001 | |||||
| BECK, Frances Jane | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | England | British | 281777720001 | |||||
| BENNETT, Martin | Director | 44 Oak Drive SY11 2RX Oswestry Shropshire | United Kingdom | British | 91573600001 | |||||
| BERTOLINI, Julie Elizabeth | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 164920860001 | |||||
| BINNS, Linda Ann | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 94578580001 | |||||
| BRENAN, Andrew John | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | England | British | 285854220002 | |||||
| BRIERLEY, Margaret | Director | 20 Clarkefields Bayston Hill SY3 0ES Shrewsbury Shropshire | British | 75157980001 | ||||||
| BUTCHER, Madeleine | Director | 16 Kennedy Road SY3 7AB Shrewsbury Shropshire | British | 75157830001 | ||||||
| CARTLIDGE, Claire Ann | Director | College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House United Kingdom | United Kingdom | British | 91573190002 | |||||
| COOPER, Penelope Angela | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | United Kingdom | British | 139225130001 | |||||
| CROSS, Bethan Mair Haulwen | Director | 15 College Hill SY1 1LY Shrewsbury Fletcher House Shropshire | Wales | British | 270042690001 | |||||
| DAVIES, Andrew Betham | Director | Spring Hill TF9 1LE Market Drayton Shropshire | British | 119102060001 | ||||||
| DAVIES, Anthony | Director | The Woodlands 2 Upper Road SY3 9JD Shrewsbury Shropshire | England | Welsh | 75157650001 | |||||
| DRUMMOND, June, Dr | Director | 31 Brownlow Road SY12 0AY Ellesmere Shropshire | British | 91887370001 | ||||||
| EVANS, Roger Arthur | Director | Brindles, Plealey, Pontesbury SY5 0UY Shrewsbury Shropshire | England | British | 85371070001 | |||||
| FINNEY, David | Director | Solaria Mill Lane Diddlebury SY7 9DJ Craven Arms Shropshire | British | 82068180001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para CITIZENS ADVICE SHROPSHIRE?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 03 dic 2016 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0